The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____...

22
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Vol. 178 Wednesday, June 10, 2020 / Le mercredi 10 juin 2020 443 ISSN 1714-9428 Notice to Readers The Royal Gazette is officially published Online. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette coordinator no later than noon, at least 7 working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the coordinator. MAY 14, 2020 2020-101 Under subsections 3(1), 3(2) and 3(4) of the New Brunswick Museum Act, the Lieutenant-Governor in Council reappoints Rebecca Moffatt, St. Andrews, New Brunswick, as a member, and appoints her as President of The Board of the New Brunswick Museum, for a term ending May 14, 2023. Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor ________________ Orders in Council Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale comme soumis. Les documents à publier doivent parvenir à le coordonna- teur de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou- vrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec le coordonnateur. LE 14 MAI 2020 2020-101 En vertu des paragraphes 3(1), 3(2) et 3(4) de la Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat Rebecca Moffatt, de Saint Andrews (Nouveau-Brunswick), membre et présidente du Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick, pour un mandat se terminant le 14 mai 2023. La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy ________________ Décrets en conseil

Transcript of The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____...

Page 1: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Vol. 178 Wednesday, June 10, 2020 / Le mercredi 10 juin 2020 443

ISSN 1714-9428

Notice to Readers

The Royal Gazette is officially published Online.Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette coordinator no later than noon, at least7 working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe coordinator.

MAY 14, 20202020-101

Under subsections 3(1), 3(2) and 3(4) of the NewBrunswick Museum Act, the Lieutenant-Governor in Councilreappoints Rebecca Moffatt, St. Andrews, New Brunswick, as amember, and appoints her as President of The Board of the NewBrunswick Museum, for a term ending May 14, 2023.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________

Orders in Council

Avis aux lecteurs

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale comme soumis. Les documents à publier doivent parvenir à le coordonna-teur de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou-vrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec le coordonnateur.

LE 14 MAI 20202020-101

En vertu des paragraphes 3(1), 3(2) et 3(4) de la Loi surle Musée du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur enconseil nomme pour un nouveau mandat Rebecca Moffatt, deSaint Andrews (Nouveau-Brunswick), membre et présidente duConseil du Musée du Nouveau-Brunswick, pour un mandat seterminant le 14 mai 2023.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

Décrets en conseil

Page 2: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale — 10 juin 2020

MAY 14, 20202020-102

1. Under subsections 20.1(1) and 20.1(2) of the WorkplaceHealth, Safety and Compensation Commission and Workers’Compensation Appeals Tribunal Act, the Lieutenant-Governorin Council appoints Kelli Simmonds, Fredericton, NewBrunswick, as Chairperson of the Workers’ CompensationAppeals Tribunal, for a term of five years, effective May 28,2020.

2. Under subsection 20.3(1) of the Workplace Health,Safety and Compensation Commission and Workers’Compensation Appeals Tribunal Act, the Lieutenant-Governorin Council fixes the remuneration for the Chairperson of theWorkers’ Compensation Appeals Tribunal at a rate equivalentto Step D, Level I of the Deputy Head Pay Plan, effectiveMay 28, 2020.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________

MAY 19, 20202020-106

1. Under subsections 24(1) and 24(2) of New BrunswickRegulation 95-61, the General Regulation under the FamilyIncome Security Act, the Lieutenant-Governor in Councilappoints the following persons as members of the FamilyIncome Security Appeal Board, for a term of three years,effective May 19, 2020:

(a) Jason Godin, Caraquet, New Brunswick, Vice-Chair;

(b) Sharon Tucker, St. George, New Brunswick;(c) Melanie Burns, Saint John, New Brunswick;(d) Mark Fisher, Saint John, New Brunswick;(e) Sherry MacEachern, Moncton, New Brunswick; and

(f) Chris Maxwell, Sackville, New Brunswick.

2. Under subsections 24(1) and 24(2) of New BrunswickRegulation 95-61, the General Regulation under the FamilyIncome Security Act, the Lieutenant-Governor in Councilreappoints the following persons as members of the FamilyIncome Security Appeal Board, for a term of three years,effective May 19, 2020:

(a) Roger Sénéchal, Beresford, New Brunswick;(b) Wilma Gilchrist, Fredericton, New Brunswick;

(c) Jami Moore, Fredericton, New Brunswick;(d) Terry Ogilvie, Salisbury, New Brunswick;(e) James Proudfoot, Moncton, New Brunswick; and

(f) Zara Morrison, Picadilly, New Brunswick.

LE 14 MAI 20202020-102

1. En vertu des paragraphes 20.1(1) et 20.1(2) de la Loi surla Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisationdes accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents autravail, le lieutenant-gouverneur en conseil nommeKelli Simmonds, de Fredericton (Nouveau-Brunswick),présidente du Tribunal d’appel des accidents au travail, pour unmandat de cinq ans, à compter du 28 mai 2020.

2. En vertu du paragraphe 20.3(1) de la Loi sur laCommission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation desaccidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents autravail, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe à un montantéquivalent à l’échelon D, niveau 1 du régime de rémunérationdes administrateurs généraux, la rémunération de la présidentedu Tribunal d’appel de la Commission de la santé, de la sécuritéet de l’indemnisation des accidents au travail, à compter du28 mai 2020.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 19 MAI 20202020-106

1. En vertu des paragraphes 24(1) et 24(2) du Règlementdu Nouveau-Brunswick 95-61 établi en vertu de la Loi sur lasécurité du revenu familial, le lieutenant-gouverneur en conseilnomme les personnes suivantes membres de la Commissiond’appel sur la sécurité du revenu familial, pour un mandat detrois ans, à compter du 19 mai 2020 :

a) Jason Godin, de Caraquet (Nouveau-Brunswick), vice-président;b) Sharon Tucker, de St. George (Nouveau-Brunswick);c) Melanie Burns, de Saint John (Nouveau-Brunswick);d) Mark Fisher, de Saint John (Nouveau-Brunswick);e) Sherry MacEachern, de Moncton (Nouveau-Brunswick); etf) Chris Maxwell, de Sackville (Nouveau-Brunswick).

2. En vertu des paragraphes 24(1) et 24(2) du Règlementdu Nouveau-Brunswick 95-61 établi en vertu de la Loi sur lasécurité du revenu familial, le lieutenant-gouverneur en conseilnomme pour un nouveau mandat les personnes suivantesmembres de la Commission d’appel sur la sécurité du revenufamilial, pour un mandat de trois ans, à compter du 19 mai2020 :

a) Roger Sénéchal, de Beresford (Nouveau-Brunswick);b) Wilma Gilchrist, de Fredericton (Nouveau-Brunswick);c) Jami Moore, de Fredericton (Nouveau-Brunswick);d) Terry Ogilvie, de Salisbury (Nouveau-Brunswick);e) James Proudfoot, de Moncton (Nouveau-Brunswick);etf) Zara Morrison, de Picadilly (Nouveau-Brunswick).

Page 3: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 445 Gazette royale — 10 juin 2020

3. Under subsections 24(1) of New Brunswick Regulation95-61, the General Regulation under the Family IncomeSecurity Act and section 26 of the Interpretation Act, theLieutenant-Governor in Council revokes section 5 of Order inCouncil 2018-67, February 22, 2018.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________

MAY 26, 20202020-109

Under section 3 of the Civil Service Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Tom MacFarlane, Fredericton,New Brunswick, as Deputy Minister of Environment and LocalGovernment, effective May 28, 2020.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

3. En vertu des paragraphes 24(1) du Règlement duNouveau-Brunswick 95-61 établi en vertu de la Loi sur lasécurité du revenu familial et de l’article 26 de la Loid’interprétation, le lieutenant-gouverneur en conseil révoquel’article 5 du décret en conseil 2018-67 pris le 22 février 2018.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 26 MAI 20202020-109

En vertu de l’article 3 de la Loi sur la Fonction publique,le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Tom MacFarlane,de Fredericton (Nouveau-Brunswick), sous-ministre del’Environnement et des Gouvernements locaux, à compter du28 mai 2020.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

North Shore Advantage Realty Ltd. Miramichi Road 716364 2020 05 12

Atlantic Skin Clinic Woodstock Inc. Woodstock 716430 2020 05 06

Florenceville Amsterdam Inn & Suites Ltd. Fredericton 716436 2020 05 06

ETC GLOBAL INC. Rothesay 716441 2020 05 07

VeriPark Software Canada Inc. Fredericton 716444 2020 05 07

Regent Park Projects Inc. Renaud Mills 716451 2020 05 07

Berwick Landing Inc. Harvey 716452 2020 05 07

Aquavation Mobile Wash Ltd. Fredericton 716463 2020 05 07

716464 NB Ltd. DSL de Drummond / LSD of Drummond 716464 2020 05 07

716467 NB Ltd. Saint John 716467 2020 05 07

BUDF DEVELOPMENT LTD. Dieppe 716468 2020 05 07

Outlaw Logging Inc. Fredericton 716470 2020 05 07

Enclosure Special Care Home Ltd. Derby Junction 716477 2020 05 08

Octanium Gas Incorporated Bathurst 716483 2020 05 08

716484 NB INC. Sainte-Rose 716484 2020 05 08

Side Gig Distilleries Limited Carters Point 716485 2020 05 08

Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer-ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 4: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 446 Gazette royale — 10 juin 2020

ROCAN Development Ltd. Memramcook 716493 2020 05 08

Outwit Adventures Inc. Quispamsis 716494 2020 05 08

Tricor Manufacturing Ltd. Fredericton 716496 2020 05 08

ACADIA LANDSCAPING (2020) INC. Cap-Pelé 716507 2020 05 11

716512 NB Inc. Shippagan 716512 2020 05 11

716516 NB INC. St George 716516 2020 05 11

Albert Management Inc. Moncton 716517 2020 05 11

BDG Services Inc. Moncton 716521 2020 05 11

La Cremerie Roule ta Crème Ice Cream & Treats Inc. Shediac 716525 2020 05 11

GDMN HOLDINGS LTD. Moncton 716527 2020 05 11

716529 NB Ltd. 716529 NB LIMITEE Penniac 716529 2020 05 11

Mallet Trading Ltd. Moncton 716530 2020 05 11

NJ HACHE TRANSPORT INC. Moncton 716531 2020 05 11

DISINFECTRE Electrostatic Services Inc. Blacks Harbour 716533 2020 05 11

716534 N.B. Inc. Kingston 716534 2020 05 11

Mopane Properties Inc. Dieppe 716537 2020 05 12

GLOROPE CANADA (NB) INC. Saint John 716541 2020 05 12

Heritage Commercial Inc. Moncton 716547 2020 05 12

RenO2blu Inc. Moncton 716549 2020 05 12

CSR Fleet Coating Inc. Sussex 716550 2020 05 12

5461 Holdings Ltd. Saint-André-LeBlanc 716554 2020 05 12

716558 N.B. Inc. Moncton 716558 2020 05 13

LMD Construction Inc. Shediac 716560 2020 05 13

DI-TECH Rénovation Inc. Brantville 716562 2020 05 13

Robert Metherell Farms Ltd. Lindsay 716570 2020 05 13

JBS TRUCKING INC. Kedgwick 716571 2020 05 13

MONCTON FREIGHT SYSTEMS INC. Moncton 716573 2020 05 13

KinderCollege Inc. Dieppe 716580 2020 05 13

716584 N.B. LTD. Grand-Sault / Grand Falls 716584 2020 05 14

Nepisiquit Roofing & Renovations Inc. Dunlop 716587 2020 05 14

AMML Entreprise Inc. EDMUNDSTON 716593 2020 05 14

Hart & Sawyer Writing and Translation Services Ltd Grand Bay-Westfield 716594 2020 05 14

DLM LOGGING INC. Kedgwick Sud 716596 2020 05 14

AIMIE DESIGN INC. Caraquet 716597 2020 05 14

Back in Balance Professional Corporation Fredericton 716598 2020 05 14

716608 N.B. Inc. Saint John 716608 2020 05 15

716610 NB INC. Grand-Barachois 716610 2020 05 15

Page 5: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 447 Gazette royale — 10 juin 2020

Dr. Mahadevaswamy Siddaiah Professional Corporation Fredericton 716611 2020 05 15

Heatherway Developments Ltd. Saint John 716614 2020 05 15

PINNACLE GLOBAL CONSULTING Inc. Quispamsis 716615 2020 05 15

TEF Properties Ltd. Riverside-Albert 716616 2020 05 15

716617 N.B. Ltd. Woodstock 716617 2020 05 15

716618 N.B. LTD. Cloverdale 716618 2020 05 15

C&A New Cart NB INC. Moncton 716623 2020 05 15

FirstLine Properties Inc. Fredericton 716624 2020 05 15

NMB Holdings Inc. Quispamsis 716625 2020 05 15

TEB Holdings Inc. Quispamsis 716626 2020 05 15

Buckley Real Estate Holdings Inc. Quispamsis 716627 2020 05 15

The Yard, Indoor Sports Facility Inc. Rusagonis 716634 2020 05 16

716641 N.B. CORP. Hampton 716641 2020 05 18

716644 N.B. Inc. Sussex 716644 2020 05 19

716645 N.B. INC. Dieppe 716645 2020 05 19

716646 N.B. Inc. Saint John 716646 2020 05 19

AB Atlantic IT Solutions Ltd. Moncton 716651 2020 05 19

BDL QUALITY HOMES LTD. Shediac 716655 2020 05 19

716658 N.B. Ltd. Saint John 716658 2020 05 19

Behfar’s Atlantic Auto Sales Ltd. Moncton 716662 2020 05 19

Claritas Financial Services Inc. Dieppe 716671 2020 05 19

716678 NB INC. Edmundston 716678 2020 05 20

Worry Pas Ta Brain Bistro Inc. Shediac 716681 2020 05 20

____________________________________________________

CHIASSON PACKING CO. LTD. - LES EMBALLAGES CHIASSON CIE.LTEE.

Chiasson Office Nouveau-Brunswick /New Brunswick

091506 2020 05 07

Food Safety Culture Inc. Upper Kent Alberta 715849 2020 05 09

____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo-rations Act, a certificate of continuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de prorogation a été émis à :

Previous ReferenceJurisdiction Number Date

Registered Office Compétence Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour

Page 6: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 448 Gazette royale — 10 juin 2020

ATLANTIC BUSINESS COLLEGE LTD. 000977 2020 05 08

H. LAW & SONS LTD. 009668 2020 05 08

COUNTRY WELLNESS INC. 509721 2020 05 08

Marcel Bélanger Electric Ltée/Ltd. 513503 2020 05 13

Goguen Truck and Trailer Repair Ltd. 612816 2020 05 07

Darren and Christie Lawrence Professional Corp. 654365 2020 05 15

GESTION GMO LTÉE 664298 2020 05 13

East Coast Prospects Inc. 668793 2020 05 15

Dr. Nicola Buckley Professional Corporation 676944 2020 05 15

PÊCHERIES MARIO GUIGNARD (2015) INC. 686306 2020 05 11

Dr. Tatum E. Buckley Professional Corporation 691667 2020 05 15

715655 NB INC. 715655 2020 05 11

_____________________________________________________

633317 N.B. LTD. CAPITAL CAULKING LTD. 633317 2020 05 15

G.F. Excavation Inc. Boudreau Backhoe Service (2017) Ltd. 696233 2020 05 07

Kormi Enterprise Ltd. Kormi Auto Lease & Financial Corp. 702563 2020 05 13

AAA Global Holding Ltd. AAA Global Holding Cannabis Ltd. 708459 2020 05 08

Quest Properties Inc. 710332 N.B. Inc. 710332 2020 05 13

WC Real Holdings Inc. 712328 N.B. Ltd. 712328 2020 05 15

Homeobay Co Inc. GeneFix Lab Inc. 715041 2020 05 11

HIGRO- HAVERST INTERNATIONAL GROUP LTD.

INTERNATIONAL OPPORTUNITIES LTD. 716360 2020 05 15

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 7: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 449 Gazette royale — 10 juin 2020

Fenero investments (2020) Ltd. Fenero investments Ltd.NOEL STATION SERVICE LTEE

Lamèque 716014 2020 05 01

_____________________________________________________

TRI-B ENTERPRISES LTD. Dieppe 016356 2020 05 15

ATLANTIC BUSINESS COLLEGE (MONCTON) LTD. Fredericton 038800 2020 05 07

SMALL BUSINESS ENTERPRISES LTD. Grand Manan 054247 2020 05 19

KENT WOODLOT SERVICES LTD. Saint-Norbert 056143 2020 05 15

Les Industries Appalache Industries Inc. Bathurst 512803 2020 05 05

BA International Inc. Saint John 628258 2020 05 13

HARRY H. WILLIAMSON PROFESSIONAL CORPORATION Bathurst 629022 2020 05 07

CNOPRO NB Inc Moncton 631441 2020 05 14

Challenge Choices Change Education Centre Inc. Saint John 646746 2020 05 07

681200 N.B. Inc. Saint John 681200 2020 05 05

682813 NB INC. Arthurette 682813 2020 05 11

GESTION IMMOBILIÈRE LANDRON INC. Dalhousie 702626 2020 05 14

_____________________________________________________

CHIASSON PACKING CO. LTD. - LES EMBALLAGES CHIASSON CIE.LTEE.

091506 2020 05 07

ATWATER HOLDINGS LTD. 508990 2020 05 13

The Cleaning Crew Inc. 509054 2020 05 07

Corvest Management International Inc. 514437 2020 05 11

635639 NB Inc. 635639 2020 05 15

SAVOIE.J.D. DISTRIBUTION INC. 652746 2020 05 05

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :

ReferenceNumber Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 8: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 450 Gazette royale — 10 juin 2020

11655604 CANADA INC. Canada Ranjit LidderGrand-Sault / Grand Falls

715797 2020 05 08

Border East Consulting Corp. Canada Andrew James GrotheBeaver Dam

716411 2020 05 05

Master Builders Solutions Canada, Inc. Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

716456 2020 04 01

Flipboard Canada, Inc. Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

716460 2020 05 05

MNP DIGITAL INC. Alberta Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

716472 2020 05 06

SOLIMINE LTD. Ontario Manon DesjardinsMoncton

716501 2020 05 11

BIOREX INC. Québec / Quebec Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

716502 2020 05 08

BELAY WEALTH INC. Alberta David McMathFredericton

716510 2020 05 08

RSA SECURITY CANADA ULC Colombie-Britannique /British Columbia

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

716526 2020 05 08

O.R.E. Auto Services Ltd. Canada Rami BaderDieppe

716536 2020 05 12

QUADZ INC. Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

716555 2020 05 12

EXTEND, INC. Delaware Cox & Palmer CorporateServices NB Inc.Saint John

716559 2020 05 12

OLOFSFORS INC. Ontario Derek LeBlancGrand-Barachois

716566 2020 05 13

Jay the Mover, INC. Canada Jason DawsonLambert’s Cove

716582 2020 05 14

LACAP PROPERTIES, INC. Manitoba Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

716643 2020 05 14

RIVERIENE FARM LTD. Saskatchewan David W McMathFredericton

716647 2020 05 15

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

Page 9: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 451 Gazette royale — 10 juin 2020

Bell Textron Canada LimitedBell Textron Canada limitée

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

077638 2020 05 04

Bell Helicopter Textron CanadaLimited Bell Helicopter TextronCanada Limitée

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

077638 2020 05 04

Bell Textron Canada LimitedBell Textron Canada limitée

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

077638 2020 05 04

1824839 ONTARIO INC. Walter D. VailFredericton

651379 2020 05 05

PARKLAND CORPORATIONCORPORATION PARKLAND

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

693665 2020 05 15

HEADSTRONG CANADA COMPANY Butlers Searching Inc.Tracy

706250 2020 05 15

_____________________________________________________

M. R. R. - MARITIME RESOURCERESEARCH LTD.

Canada G. Christopher RobertsFredericton

019778 2020 05 06 2020 08 06

MACQUARIE SECURITIESFINANCING LTD. (CANADA)

Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

649561 2020 05 06 2020 08 06

GRANT THORNTON RAYMOND CHABOT INFRASTRUCTURE INC.

Ontario Peter R. ForestellSaint John

653966 2020 05 06 2020 08 06

ENERGY EAST PIPELINE LTD.OLÉODUC ÉNERGIE EST LTÉE

Canada William H. TeedSaint John

669425 2020 05 06 2020 08 06

HOLLOWAY LODGING CORPORATION

Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

681267 2020 05 06 2020 08 06

LES PÉTROLES C. POIRIER INC. Québec / Quebec Chauffage BenwellFuels Ltd.Campbellton

682282 2020 05 06 2020 08 06

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :

ReferenceNumber Date

Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, the Director has made a decision to cancel the registrationof the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, leDirecteur a décidé d’annuler l’enregistrement des corporations extra-provinciales suivantes :

Proposed CancellationReference Notice Date Date / Date deNumber Date de l’avis l’annulation projetée

Jurisdiction Agent Numéro de Year Month Day Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour année mois jour

Page 10: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 452 Gazette royale — 10 juin 2020

RED CLOUD KLONDIKESTRIKE INC.

Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

685144 2020 05 06 2020 08 06

POSERA LTD. Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

694535 2020 05 06 2020 08 06

COTT CORPORATIONCORPORATION COTT

Canada Cox & Palmer CorporateServices NB Ltd.Moncton

715371 2020 05 06 2020 08 06

_____________________________________________________

D-CANACO TRADING INC. Canada Richard AlbertCaraquet

074731 2020 05 08

Cal LeGrow Insurance Limited Terre-Neuve-et- Labrador / Newfoundland and Labrador

Andrew LoganSaint John

696825 2020 05 06

_____________________________________________________

FLYNN CANADA LTD. FLYNN CANADA LTD. April L ParkerMoncton

716499 2020 05 06

PENNER INTERNATIONAL INC.

SLH Transport Inc.Transport SLH Inc.

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

716500 2020 05 07

FU HUI BUDDHIST ASSOCIATION INC. Fredericton 716488 2020 05 08

HOSPICE RIVER VALLEY INC. Woodstock 716592 2020 05 14

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of reinstatement has been issued to the follow-ing extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de rétablissement a été émis aux corporations extrapro-vinciales suivantes :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :

ReferenceAgent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,

letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres

patentes ont été émises à :ReferenceNumber Date

Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour

Page 11: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 453 Gazette royale — 10 juin 2020

FUTUR DE SAINTE-ANNE INC. 658088 2020 05 05

Nicholas’ Hope Family Services Inc. 694647 2020 05 19

_____________________________________________________

THE OLD ACADIAN TRAIL ALONG THE PETITCODIAC RIVER/L’ANCIEN SENTIER SUR LE LONG DE LA RIVIERE DE LA PETITCODIAC

Allied Industries Limited Moncton 715972 2020 05 06

Les petits projets de construction Jérôme St-Coeur / Jérôme St-Coeur small construction projects

Jérôme St-Coeur Bas-Caraquet 716237 2020 04 24

Jesso’s Maritime Carpentry Harvey Jesso Saint John 716294 2020 04 29

ShooFly Pest Control Atlantic Ryan MacPhail Miramichi 716401 2020 05 04

Millstream Accounting Services David Pike Lower Millstream 716407 2020 05 05

Orthotic Works Atlantic Division David Chesson Beresford 716408 2020 05 05

CREATIVE LIFESTYLES STUDIO Jordan Hollingsworth Saint John 716414 2020 05 05

Moon light tattoo parlour Ryan Mclaughlin Fredericton 716434 2020 05 06

Donna Steeves Contracting Donna Steeves Hopewell Hill 716435 2020 05 06

ROAD TO RIVER AUTO AND POWER SPORTS

688463 N.B. LTD. Colpitts Settlement 716439 2020 05 07

Maritime Pro Seal Jonathan Hurshman Moncton 716442 2020 05 07

Vanessa Lees RMT Vanessa Lees Burton 716443 2020 05 07

MC Growth Space & Consulting Mathieu Collin Fredericton 716446 2020 05 07

C RAVEN ELECTRICAL Cory H.J. Raven Saint John 716449 2020 05 07

P.G.Landscaping Yves Gaudreault Sackville 716450 2020 05 07

Wingo’s Restaurant Wingo Au Woodstock 716453 2020 05 07

Marcoux Construction Mark Marcoux Hillsborough 716455 2020 05 07

PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the followingcompany is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act:

SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituéeen vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 12: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 454 Gazette royale — 10 juin 2020

DairyTown Yard Service Greg Nutter Southfield 716457 2020 05 07

Bee Kind Factory Crooked River Farm Inc. Memramcook 716458 2020 05 07

CAMPOBELLO LOBSTER Garry Chute Wilsons Beach 716459 2020 05 07

The Biz Hub Nicole Landry Caraquet 716474 2020 05 07

Legere’s Cabinets and Construction Richard Legere Baie Verte 716476 2020 05 07

LOG(X) SOLUTIONS Alex Amellal Moncton 716478 2020 05 08

Tradewinds Imports 707834 N.B. Ltd. St Andrews 716481 2020 05 08

STEWART FORESTWORKS Daniel Stewart Oak Bay 716482 2020 05 08

Payroc WINTERLAND BUYER, INC. Saint John 716487 2020 05 08

Payroc Canada WINTERLAND BUYER, INC. Saint John 716489 2020 05 08

Claim Restore 668339 NB INC. Dieppe 716490 2020 05 08

Llama-zing Adventures Josée Gautreau Haute-Aboujagane 716491 2020 05 08

JD design & custom Jean Daniel Dufour Saint-Quentin 716497 2020 05 08

Adele Music Patti F. Morley Turtle Creek 716503 2020 05 09

Miramichi Counselling Centre Pamela MacDonald Miramichi 716505 2020 05 10

Eddy Realty GEORGE EDDY COMPANY, LIMITED

Bathurst 716506 2020 05 11

LOCATION LAFRANCE Toby Lafrance Edmundston 716508 2020 05 11

Fridgee Foods Black Duck Restaurants Incorporated

Sackville 716513 2020 05 11

StoragePods4U 669155 NB INC. Quispamsis 716514 2020 05 11

Chalet Cap Pelé Dre Nicole LeBlanc C.P. Inc. Cap-Pelé 716515 2020 05 11

Daley Farms Gerald Daley New Bandon 716518 2020 05 11

ABUNDANT HEALTHY SNACK FOODS

705394 NB INC. Cocagne 716520 2020 05 11

Star Transport Fredericton 11655604 CANADA INC. Grand-Sault / Grand Falls 716523 2020 05 11

Lucy Loo’s Crafts Gina Cummins Island View 716524 2020 05 11

Best Kind Entertainment Jonathan Hache Moncton 716532 2020 05 11

Mylene LeBlanc Esthetique Mylene Leblanc Dieppe 716535 2020 05 11

Unsettled Media Navi Group Consulting Inc. Saint John 716538 2020 05 12

TJ.News Brunswick News Inc.Nouvelles Brunswick Inc.

Saint John 716540 2020 05 12

Richardson Sanitech Mark Richardson Fredericton 716542 2020 05 12

BM Burns Renovations Benjamin Dwight Burns Saint John 716545 2020 05 12

Fierce Tarot Readings RoseAnne Helena Maria Bishop Sussex 716546 2020 05 12

Fresh n Wild Seafood Products James P. Ward Eel Ground 716548 2020 05 12

Status Misunderstood Alexis Belliveau Dieppe 716553 2020 05 12

Diamond Energy Therapy-Lisa Morissette

Lisa Morissette Woodstock 716556 2020 05 12

Page 13: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 455 Gazette royale — 10 juin 2020

The Junction Food Company Riverhaven Acres Inc. Fredericton Junction 716561 2020 05 13

Sussex Barber Shop Matthew White Sussex 716563 2020 05 13

Prestige Fresh Air Janielle Leger Boudreau Cap-Pelé 716564 2020 05 13

Jenny’s Permanent Makeup Lab Evgenia Strelkov Fredericton 716565 2020 05 13

Alysha Trenholm Childbirth Education Alysha Trenholm Moncton 716569 2020 05 13

Petitcodiac Community Hub Donald Bowser Petitcodiac 716572 2020 05 13

ECT Industries Gina Taylor Première nation deBurnt Church / Burnt Church First Nation

716575 2020 05 13

Kormi Auto Lease Kormi Enterprise Ltd. Fredericton 716576 2020 05 13

Terris Refrigeration Anthony Terris Shenstone 716578 2020 05 13

Songtrue Xpression Charline Savoie Grand-Barachois 716579 2020 05 13

Maritime Soapery Juanita Tremblay Williamstown 716583 2020 05 14

Edible Landscapes Michael R.W. Sorenson Noonan 716585 2020 05 14

She Shed Nailz Krista Constantine Moncton 716586 2020 05 14

Clinique médicale Centre Ville Dr Marc-André Doucet c.p. inc. Beresford 716589 2020 05 14

The Wild side protection and conservation / conservation et protection coté sauvage

Marc-André Benoit Lamèque 716591 2020 05 14

CONSTRUCTION ARC EN CIEL Charles Levesque Saint-Léonard-Parent 716595 2020 05 14

CAFE LA FRINGALE Cedric Megy Caraquet 716599 2020 05 14

Éditions Plume noire Yvon Gaudet Dalhousie 716601 2020 05 14

MISCOU LOBSTER SHOP PECHERIES LLOYD WARD INC. Miscou 716603 2020 05 14

Les Jardins de la Flamme d’Amour Marie Céline Grenier Shemogue 716604 2020 05 14

Triple D Landscaping & Odd Jobs Donald Henderson Oromocto 716605 2020 05 14

Arts et Bien-Être par Chantal Chantal Cool Dieppe 716607 2020 05 15

R.C. GENERAL MECHANIC Ricky Comeau Lavillette 716612 2020 05 15

RÉSIDENCE DE L’HARMONIE ONTASK HOSPITALITY GROUP INC.

Shediac 716613 2020 05 15

ROYAL LePAGE PARKWOOD REALTY

BOULEG HOLDINGS INC. Bathurst 716621 2020 05 15

Lanteigne Trading Group Jean-Rene Lanteigne Campbellton 716630 2020 05 15

Kiwi Nutrition & Wellness Monica Lavoie Memramcook 716637 2020 05 16

GreenZen Studio Matthew MacIsaac Moncton 716638 2020 05 18

Vitropure Lavage de vitres Mathieu Turcotte Caraquet 716639 2020 05 18

Woodstock Dentistry Aditya M. BhallaProfessional Corporation

Woodstock 716657 2020 05 19

TerpinTymes Novelties Geordie Thibodeau Saint John 716659 2020 05 19

André Roy consultant immobilier André Roy Moncton 716660 2020 05 19

Page 14: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 456 Gazette royale — 10 juin 2020

Sylvain Morin & AssociatesPrivate Wealth Management

INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.

Moncton 716663 2020 05 19

AJS coatings Andrew Savoie Miramichi 716664 2020 05 19

M & M Asphalt Sealing Mathieu Maltais Campbellton 716665 2020 05 19

Hollow Creek Stables Amanda Young Jemseg 716666 2020 05 19

Pleasant Valley Counselling Jessica McMillan Sussex Corner 716669 2020 05 19

HBB Resources Kelsey Bryant Bethel 716675 2020 05 20

Dom’s Speed Shop Dominic Luc Côté Grand-Sault / Grand Falls 716677 2020 05 20

BrownPenney Hospitality Carol Brown Grand-Barachois 716679 2020 05 20

Carnivora Pet Foods RIVERIENE FARM LTD. Fredericton 716683 2020 05 20

_____________________________________________________

RESIDENCE ANCIENNE JEUNESSE

LA SOCIETE D’HABITATION DE ROGERSVILLE INC.

Rogersville 301342 2020 05 11

EDDY WHOLESALE EDDY GROUP LIMITED Bathurst 320799 2020 05 11

EDDY HARDWARE EDDY GROUP LIMITED Bathurst 320800 2020 05 11

RS ACCOUNTING SERVICES 611281 N.B. Inc. Fredericton 615810 2020 05 13

Entreprises MARS Communications Enrg.

607873 N.B. INC. Tracadie-Sheila 618242 2020 05 20

Sarah Jayne Design Sarah Doiron Moncton 618782 2020 05 17

THRIFTY’S THRIFTYS INC. (2005) Saint John 619251 2020 05 08

BLUENOTES THRIFTYS INC. (2005) Saint John 619252 2020 05 08

ADDITION ELLE 14+ REITMANS (CANADA) LIMITED REITMANS (CANADA) LIMITÉE

Saint John 619651 2020 05 11

ADDITION ELLE REITMANS (CANADA) LIMITED REITMANS (CANADA) LIMITÉE

Saint John 619652 2020 05 11

THYME MATERNITY REITMANS (CANADA) LIMITED REITMANS (CANADA) LIMITÉE

Saint John 619653 2020 05 11

Bear in Mind Collectibles Linda Joan Chiasson Dieppe 626018 2020 05 13

MIKE’S TREE SERVICE Michael R.W. Sorenson Noonan 648779 2020 05 13

Rail’s Cleaning Services Marlene Ann Rail Dieppe 650750 2020 05 14

Glidden PPG Architectural Coatings Canada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650920 2020 05 08

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 15: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 457 Gazette royale — 10 juin 2020

ICI Paints PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650921 2020 05 11

Color Your World PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650922 2020 05 08

ICI PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650923 2020 05 08

Glidden Paints PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650925 2020 05 08

ICI Canada PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650926 2020 05 08

Mills PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650927 2020 05 08

Mills Paints PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650928 2020 05 08

Mulco PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650929 2020 05 08

Prilco PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650930 2020 05 08

Sico PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650931 2020 05 08

Dulux PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650934 2020 05 08

Betonel PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650936 2020 05 08

CIL PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650937 2020 05 08

CYW PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650938 2020 05 08

Dulux Paints PPG Architectural CoatingsCanada, Inc. PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.

Saint John 650940 2020 05 08

BURNS & WILCOX CANADA BURNS & WILCOX CANADA, ULC

Saint John 669760 2020 05 15

BURNS & WILCOX BURNS & WILCOX CANADA, ULC

Saint John 669761 2020 05 15

Nashwaak Valley Farms Michael R.W. Sorenson Noonan 680967 2020 05 13

East Coast Rustic Michael Cosman Saint John 681003 2020 05 13

KEVIN’S COMPUTER & ELECTRONIC REPAIRS

Kevin Letteney St Stephen 682143 2020 05 11

Page 16: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 458 Gazette royale — 10 juin 2020

Reckoning Statistics and Program Evaluation

Cynthia Doucet Taylor Village 682503 2020 05 09

Five Star Preowned BAYSIDE CHRYSLER DODGE LTD.

Bathurst 682684 2020 05 11

Emmerson Packaging EPC INDUSTRIES LIMITED/INDUSTRIES EPC LIMITÉE

Fredericton 683038 2020 05 13

North Market Seafood True North Salmon Co. Ltd. Saint John 683584 2020 05 08

Oil Change Express Coast Tire & Auto Service Ltd. Saint John 683585 2020 05 11

Generate Creative Consulting Genevieve Coates St Stephen 683854 2020 05 13

CAbi CABI CANADA, LTD. Saint John 683925 2020 05 19

_____________________________________________________

EDDY REALTY Bathurst 321382 2020 05 08

TAURUS TEC Riverview 349640 2020 05 08

ICI Devoe Saint John 650932 2020 05 10

ICI Devoe Coatings Saint John 650933 2020 05 10

Devoe Coatings Saint John 650939 2020 05 10

Tradewinds Imports St Andrews 665981 2020 05 08

Aquavation Mobile Wash Fredericton 674115 2020 05 05

Aimie Design Caraquet 682899 2020 05 14

PGP THERMAL Saint John 683418 2020 05 14

ROYAL LEPAGE PARKWOOD REALTY Bathurst 684974 2020 05 15

Rami Shokri Business Accountant Fredericton 700987 2020 05 11

VOIPINC Communications Fredericton 700990 2020 05 11

Bistro ludique LE MOQUE-TORTUE Games Bistro Shediac 702735 2020 05 15

EFSR Building Services Cocagne 705422 2020 05 11

Back in Balance Massage Therapy Clinic Fredericton 706614 2020 05 14

Quest Properties Moncton 715124 2020 05 14

Clinique médicale Centre Ville Bathurst 715968 2020 05 13

HBB Resources Bethel 716396 2020 05 20

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Page 17: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 459 Gazette royale — 10 juin 2020

Maxwell Brothers Trucking Jordan MaxwellJeremy Maxwell

Lower Coverdale 716440 2020 05 05

Askew Commercial Cleaning Lisa MailmanBrandon Askew

Saint John 716448 2020 05 07

Lagoon Aeration Systems Maintenance Robert Luke ColpittsDieter Jan Burgess

Saint John 716469 2020 05 07

StrongLine Painting & Moving Trevor John RobichaudChristopher Bruce Brown

Moncton 716522 2020 05 11

OCTANE DEVELOPMENTS 12th Avenue Consulting Inc.691968 New Brunswick Inc./691968 Nouveau-Brunswick Inc.713777 NB Ltd. Vicki Wallace-Godbout

Première nation malécite du Madawaska / Madawaska Maliseet First Nation

716568 2020 05 13

_____________________________________________________

Emotional Fitness Institute Alternative Options Coaching Dieppe 707473 2020 05 05

VIGNOBLE LA BUTTE ST-MARTINHILL VINEYARD

VIGNOBLE LA BUTTE ST-MARTINHILL VINYARD

Cocagne 716105 2020 05 15

_____________________________________________________

Orthotic Works Atlantic Division Beresford 705889 2020 05 05

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of firmname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement de raison sociale a été enregistré :

Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Date

Previous Name commerce ou Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Page 18: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 460 Gazette royale — 10 juin 2020

Shannon & Buffett, LLP, CPAs Claude C. Leger Claude C. Leger Professional Corporation

616534 2020 05 13

Creative Supply Productions Richard LeBlanc 707230 2020 05 05

_____________________________________________________

MCPM INVERSIONES LP AGMP INVERSIONES GP LLC

Saint John 716551 2020 05 11

AGET INVERSIONES LP AGMP INVESTIONES GP LLC

Saint John 716552 2020 05 11

_____________________________________________________

Astra Investments LP Astra Investments GP LLC Saint John 708337 2020 05 15

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of member-ship of partnership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Retiring Partners Incoming Partners Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Associés sortants Nouveaux associés référence année mois jour

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of limited partnership has been filed by:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite a été déposée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date

General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of dissolution of limited partnership hasbeen filed by:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de dissolution de société en commandite a été déposéepar :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date

General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

Page 19: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 461 Gazette royale — 10 juin 2020

Montagu IV L.P. Saint John Royaume-Uni / United Kingdom

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

683608 2020 05 15

Montagu V (US) L.P. Saint John Royaume-Uni / United Kingdom

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

683609 2020 05 15

HACH SALES & SERVICECANADA LP

Saint John Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

716495 2020 05 06

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership hasbeen filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-sée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Agent and Address Number DatePrincipal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

NOTICE OF INTENT TO APPLYFOR A TITLE DECLARATION

(Form 70A)

TO WHOM IT MAY CONCERNTAKE NOTICE THAT:Winsford Holdings Ltd. (the “Plaintiff”) c/o John J.MacGillivray, Gorman Nason, 121 Germain Street, P.O.Box 7286, Station A, Saint John, NB, E2L 4S6, intends to applyfor a title declaration in relation to land located in St. Andrews,County of Charlotte and Province of New Brunswickcommonly known as Frederick Street.

The title declaration sought is as follows:

Frederick Street, or a portion thereof, as set out in the Planof Survey entitled “Her Majesty the Queen in Right of theProvince of New Brunswick represented by the Ministerof Agriculture, Aquaculture and Fisheries Property,Beings Lands Quit Claimed by/to Winsford HoldingsLtd., being Lands Formerly Reserved for Frederick StreetExtension, Town of Saint Andrews, Parish of SaintAndrews, Charlotte County, New Brunswick” datedApril 24, 2020, prepared by Wade M. McNutt, a copy ofwhich is attached hereto, is partly owned by the Plaintiffin fee simple or, in the alternative, the Plaintiff has aneasement over Frederick Street for all purposes ingressand egress or, in the further alternative, Frederick Streetis public street by dedication.

The title declaration, if granted, will bind all persons.

If you dispute or question the proposed title declaration in anyway, you must, no later than the 17th day of July, 2020, send a

NoticesAVIS D’INTENTION DE SOLLICITER UNE DÉCLARATION DE TITRE DE PROPRIÉTÉ

(Formule 70A)

À QUI DE DROITSACHEZ QUE : Winsford Holdings Ltd. (le «plaignant»), a/s deJohn J. MacGillivray, Gorman Nason, 121, rue Germain,C.P. 7286, succursale A, Saint John (Nouveau-Brunswick),E2L 4S6, entend solliciter une déclaration de titre de propriétérelativement au bien-fonds sis à St. Andrews, comté deCharlotte, province du Nouveau-Brunswick, communémentappelé rue Frederick.

La déclaration de titre de propriété recherchée est ainsi établie :

La rue Frederick, en tout ou en partie, correspondant à ladescription du plan d’arpentage intitulé «Her Majesty theQueen in Right of the Province of New Brunswick representedby the Minister of Agriculture, Aquaculture and FisheriesProperty, Beings Lands Quit Claimed by/to Winsford HoldingsLtd., being Lands Formerly Reserved for Frederick StreetExtension, Town of Saint Andrews, Parish of Saint Andrews,Charlotte County, New Brunswick», établi le 24 avril 2020,dressé par Wade M. McNutt, dont une copie est jointe enannexe, appartient partiellement au plaignant en fief simple ou,à titre subsidiaire, le plaignant ayant une servitude sur la rueFrederick à des fins de libre circulation ou, à titre trèssubsidiaire, la rue Frederick étant désignée rue publique.

Si elle est accordée, la déclaration de titre de propriété lieratoutes les personnes. Si vous contestez ou mettez en question de quelque façon quece soit la déclaration de titre de propriété proposée, vous devez,au plus tard le 17 juillet 2020, envoyer un contredit à l’adresse

Avis

Page 20: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 462 Gazette royale — 10 juin 2020

indiquée ci-après à la personne qui donne le présent avis et yénoncer les motifs de votre opposition. À cette fin, vous pouvezvous servir de la formule 70B des Règles de procédure. Vousdevez y énoncer les motifs de votre opposition. En casd’omission d’envoyer le contredit au plus tard à cette date, uneinstance pourra être introduite et une déclaration de titre depropriété pourra être accordée sur le fondement de votreabsence d’opposition.

FAIT à Saint John, au Nouveau-Brunswick, le 27 mai 2020.

John J. MacGillivrayGORMAN NASONGorman NasonAvocatsCase postale 7286, succursale A121, rue GermainSaint John (Nouveau-Brunswick) E2L [email protected]éléphone : 506-634-8600 Télécopieur : 506-634-8685

dispute note to the person giving this notice at the address givenbelow. Form 70B of the Rules of Court may be used for adispute note. You must indicate the reasons for the objection inyour dispute note. If you fail to send a dispute note by that date,a proceeding may be commenced and a title declaration grantedon the basis that you do not oppose it.

DATED at the City of Saint John, Province of New Brunswick,this 27th day of May, 2020.

John J. MacGillivrayGORMAN NASONGorman NasonBarristers & SolicitorsP.O. Box 7286, Station A121 Germain St.Saint John, NB E2L [email protected]: 506.634.8600 Fax: 506.634.8685

Page 21: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 463 Gazette royale — 10 juin 2020

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformémentà la Loi sur la publication des avis officiels. Les documents àpublier doivent être soumis au coordonnateur de la Gazetteroyale en format Microsoft Word, avant midi, au moins septjours avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être sé-paré de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doiventsuivre immédiatement la signature. Le coordonnateur de la Ga-zette royale peut refuser de publier un avis dont une partie estillisible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ad-ministratives.Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :

Les paiements peuvent être faits par chèque ou mandat (àl’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement en ligne chaque mercredi.

Gazette royale

Avis Droit

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, que prévoient les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau

20 $

Avis d’examen qu’exige la Loi sur les infirmières et infirmiersauxiliaires autorisés

25 $

Avis qu’exige la Loi sur les transports routiers 30 $Avis aux créanciers prévu par le Règlement du Nouveau-

Brunswick 84-9 pris en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions

20 $

Avis qu’exige la Règle 70 des Règles de procédureNota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser

8,5 po sur 14 po

120 $

Avis de vente d’un bien que prévoit une loi, si l’avis mesureune demi-page ou moins

20 $

Avis de vente d’un bien que prévoit une loi, si l’avis est deplus une demi-page

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis de correction les droits sont les mêmes que

ceux exigés pour la

publication du document original

Tout autre document 3,50 $ pour ch-aque cm

(arrondi au cm supérieur)

Avis aux annonceurs

The Royal Gazette is published every Wednesday under the au-thority of the Official Notices Publication Act. Documents mustbe sent to the Royal Gazette coordinator in Microsoft Word for-mat, no later than noon, at least seven days prior to Wednes-day’s publication. Each document must be separate from thecovering letter. Signatures on documents must be immediatelyfollowed by the printed name. The Royal Gazette coordinatormay refuse to publish a document if any part of it is illegible,and may delay publication of any document for administrativereasons.Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:

Payments can be made by cheque or money order (payable tothe Minister of Finance). No refunds will be issued for cancel-lations.

The official version of The Royal Gazette is available freeOnline each Wednesday.

The Royal Gazette

Notices Fee

Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill

$ 20

Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the General Rules under the Law Society Act,

1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9

under the Probate Court Act$ 20

Notice under Rule 70 of the Rules of CourtNote: Survey Maps cannot exceed 8.5 x 14

$120

Notice of sale of property under an Act, if the notice is 1/2 pageor less

$ 20

Notice of sale of property under an Act, if the notice is greaterthan 1/2 page

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)

$ 20

Notice of a correction fee is the same as

for publishing the original document

Any other document $3.50 for each cm (rounded

up to the nearest cm)

Notice to Advertisers

Page 22: The Royal Gazette / Gazette royale (20/06/10) · La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy _____ Décrets en conseil. The Royal Gazette — June 10, 2020 444 Gazette royale —

The Royal Gazette — June 10, 2020 464 Gazette royale — 10 juin 2020

Services Nouveau-BrunswickPlace Brookside

435, promenade Brookside, bureau 30C.P. 6000

Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tél. : 506-453-3864Courriel : [email protected]

Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doitêtre remise à la réception.

Service New BrunswickBrookside Place

435 Brookside Drive, Suite 30P.O. Box 6000

Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-3864E-mail: [email protected]

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette andleft at the reception.

SERVICE NEW BRUNSWICK © SERVICES NOUVEAU-BRUNSWICKAll rights reserved / Tous droits réservés