The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette...

21
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Vol. 170 Wednesday, April 18, 2012 / Le mercredi 18 avril 2012 679 ISSN 1714-9428 Notice to Readers The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least seven working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator at 453-8372. DECLARATION IN THE MATTER OF THE MUNICIPAL ELECTIONS ACT BY-ELECTIONS and RURAL COMMUNITY FIRST ELECTION, NOVEMBER 15, 2010 Under subsection 19(1) and subsection 41(5) of the Municipal Elections Act, I, Michael P. Quinn, Municipal Electoral Officer, do hereby declare the following candidates to be elected to the offices indicated hereunder. Elections New Brunswick Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à la coordon- natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale au 453-8372. DÉCLARATION LOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ÉLECTIONS PARTIELLES et PREMIÈRE ÉLECTION D’UNE COMMUNAUTÉ RURALE, LE 15 NOVEMBRE 2010 En vertu du paragraphe 19(1) et paragraphe 41(5) de la Loi sur les élections municipales, je, Michael P. Quinn, directeur des élections municipales, déclare les candidat(e)s suivant(e)s élu(e)s aux postes indiqués. Élections Nouveau-Brunswick

Transcript of The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette...

Page 1: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Vol. 170 Wednesday, April 18, 2012 / Le mercredi 18 avril 2012 679

ISSN 1714-9428

Notice to Readers

The Royal Gazette is officially published on-line.

Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.

Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette Coordinator no later than noon, at leastseven working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe Royal Gazette Coordinator at 453-8372.

DECLARATIONIN THE MATTER OF THE

MUNICIPAL ELECTIONS ACTBY-ELECTIONS and RURAL COMMUNITY FIRST

ELECTION, NOVEMBER 15, 2010Under subsection 19(1) and subsection 41(5) of the MunicipalElections Act, I, Michael P. Quinn, Municipal Electoral Officer,do hereby declare the following candidates to be elected to theoffices indicated hereunder.

ElectionsNew Brunswick

Avis aux lecteurs

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.

Les documents à publier doivent parvenir à la coordon-natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept joursouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de laGazette royale au 453-8372.

DÉCLARATIONLOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

ÉLECTIONS PARTIELLES et PREMIÈRE ÉLECTIOND’UNE COMMUNAUTÉ RURALE,

LE 15 NOVEMBRE 2010En vertu du paragraphe 19(1) et paragraphe 41(5) de la Loi surles élections municipales, je, Michael P. Quinn, directeur desélections municipales, déclare les candidat(e)s suivant(e)sélu(e)s aux postes indiqués.

ÉlectionsNouveau-Brunswick

Page 2: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 680 Gazette royale — 18 avril 2012

DATED at the City of Fredericton, County of York, Province ofNew Brunswick, this 26th day of November, 2010.

Michael P. QuinnMunicipal Electoral Officer

________________

DECLARATIONIN THE MATTER OF THE

MUNICIPAL ELECTIONS ACTBY-ELECTIONS, DECEMBER 13, 2010

Under subsection 19(1) and subsection 41(5) of the MunicipalElections Act, I, Michael P. Quinn, Municipal Electoral Officer,do hereby declare the following candidates to be elected to theoffices indicated hereunder.

NAME CANDIDATE OFFICE

TOWNSWoodstock Randy Leonard Councillor at large

VILLAGESBlacks Harbour Carolyn M. Breau Councillor at largeGagetown Janice A. Perry Councillor at largeMinto Kris Steven Austin Councillor at largePointe-Verte Daniel Guitard Councillor at largeSainte-Anne-de-Madawaska

Martin (Blue) ParentRichard (Bie) Parent

Councillor at largeCouncillor at large

St. Hilaire Benoît DumontMarc Morin

MayorCouncillor at large

Stanley James F. Pinnock Councillor at largeSussex Corner Lisa C. Hutchinson Councillor at large

RURAL COMMUNITIESCampobello Island Stephen David Smart Mayor

Carson R. Savage Councillor at largeKevin E. Sawtelle Councillor, Ward 1Terrance Dale Preston Councillor, Ward 2Janice M. Watters Councillor, Ward 3

NAME CANDIDATE OFFICE

CITIESSaint John Mel Norton Councillor, Ward 3

TOWNSGrand Bay-Westfield Mike Likely Councillor at largeRiverview Martha Shaw-Murphy Councillor at large

VILLAGESBlackville Hal P. Muck Councillor at large

RURAL COMMUNITIESBeaubassin East Gilles Cormier Councillor, Ward 2

FAIT dans la cité de Fredericton, comté d’York au Nouveau-Brunswick, le 26 novembre 2010.

Michael P. QuinnDirecteur des élections municipales

________________

DÉCLARATIONLOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

ÉLECTIONS PARTIELLES, LE 13 DÉCEMBRE 2010

En vertu du paragraphe 19(1) et paragraphe 41(5) de la Loi surles élections municipales, je, Michael P. Quinn, directeur desélections municipales, déclare les candidat(e)s suivant(e)sélu(e)s aux postes indiqués.

NOMCANDIDAT OU

CANDIDATE POSTE

VILLESWoodstock Randy Leonard Conseiller général

VILLAGESBlacks Harbour Carolyn M. Breau Conseillère généraleGagetown Janice A. Perry Conseillère généraleMinto Kris Steven Austin Conseiller généralPointe-Verte Daniel Guitard Conseiller généralSainte-Anne-de-Madawaska

Martin (Blue) ParentRichard (Bie) Parent

Conseiller généralConseiller général

St. Hilaire Benoît DumontMarc Morin

MaireConseiller général

Stanley James F. Pinnock Conseiller généralSussex Corner Lisa C. Hutchinson Conseillère générale

COMMUNAUTÉS RURALESCampobello Island Stephen David Smart Maire

Carson R. Savage Conseiller généralKevin E. Sawtelle Conseiller, Quartier 1Terrance Dale Preston Conseiller, Quartier 2Janice M. Watters Conseillère, Quartier 3

NOMCANDIDAT OU

CANDIDATE POSTE

CITÉSSaint John Mel Norton Conseiller, Quartier 3

VILLESGrand Bay-Westfield Mike Likely Conseiller généralRiverview Martha Shaw-Murphy Conseillère générale

VILLAGESBlackville Hal P. Muck Conseiller général

COMMUNAUTÉS RURALESBeaubassin-est Gilles Cormier Conseiller, Quartier 2

Page 3: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 681 Gazette royale — 18 avril 2012

DATED at the City of Fredericton, County of York, Province ofNew Brunswick, this 29th day of January, 2011.

Michael P. QuinnMunicipal Electoral Officer

________________

DECLARATIONIN THE MATTER OF THE

MUNICIPAL ELECTIONS ACTBY-ELECTIONS, MAY 9, 2011

Under subsection 19(1) and subsection 41(5) of the MunicipalElections Act, I, Michael P. Quinn, Municipal Electoral Officer,do hereby declare the following candidates to be elected to theoffices indicated hereunder.

DATED at the City of Fredericton, County of York, Province ofNew Brunswick, this 29th day of January, 2011.

Michael P. QuinnMunicipal Electoral Officer

________________

NAME CANDIDATE OFFICE

CITIESCampbellton Ian Comeau Councillor at large

TOWNSBeresford Gilles A. Halley Councillor at largeQuispamsis Libby O’Hara Councillor at largeRichibucto Roger Doiron Mayor

VILLAGESAlma Ryan H. Butland Councillor at largeBlacks Harbour Natalie C. Harris Councillor at largeCanterbury Jeremy T. Roussell Councillor at largeCentreville Lottie R. Nye Councillor at largeNorton Juliana Catherine

BoothCouncillor at large

Plaster Rock Alexis Doireann Fenner

Councillor at large

Rogersville Pierrette Robichaud MayorSainte-Marie-Saint-Raphaël

Corinne Savoie Councillor at large

RURAL COMMUNITIESCampobello Island Raymond C. Brown,

Sr.Councillor at large

FAIT dans la cité de Fredericton, comté d’York au Nouveau-Brunswick, le 19 janvier 2011.

Michael P. QuinnDirecteur des élections municipales

________________

DÉCLARATIONLOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

ÉLECTIONS PARTIELLES, LE 9 MAI 2011

En vertu du paragraphe 19(1) et paragraphe 41(5) de la Loi surles élections municipales, je, Michael P. Quinn, directeur desélections municipales, déclare les candidat(e)s suivant(e)sélu(e)s aux postes indiqués.

FAIT dans la cité de Fredericton, comté d’York au Nouveau-Brunswick, le 29 janvier 2011.

Michael P. QuinnDirecteur des élections municipales

________________

NOMCANDIDAT OU

CANDIDATE POSTE

CITÉSCampbellton Ian Comeau Conseiller général

VILLESBeresford Gilles A. Halley Conseiller généralQuispamsis Libby O’Hara Conseillère généraleRichibucto Roger Doiron Maire

VILLAGESAlma Ryan H. Butland Conseiller généralBlacks Harbour Natalie C. Harris Conseillère généraleCanterbury Jeremy T. Roussell Conseiller généralCentreville Lottie R. Nye Conseillère généraleNorton Juliana Catherine

BoothConseillère générale

Plaster Rock Alexis Doireann Fenner

Conseillère générale

Rogersville Pierrette Robichaud MaireSainte-Marie-Saint-Raphaël

Corinne Savoie Conseillère générale

COMMUNAUTÉS RURALESCampobello Island Raymond C. Brown,

Sr.Conseiller général

Page 4: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012

Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3, Province of New Brunswick, the following changes to the original registra-tions have been entered in the Registry of Political Parties between March 1st, 2012 and March 31st, 2012: / Conformément à l’article149 de la Loi électorale, chapitre E-3, province du Nouveau-Brunswick, les changements suivants aux enregistrements originaux ontété inscrits au registre des partis politiques entre le 1er mars 2012 et le 31 mars 2012 :

11 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF MIRAMICHI-BAY DU VIN (District No. 11) / ASSOCIATION DU PARTILIBÉRAL DE MIRAMICHI-BAIE-DU-VIN (Circonscription no 11)

Official Representative / Représentant officiel Lloyd Cameron51, rue Howard StreetMiramichi, NB E1N 1V6

46 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF NEW MARYLAND-SUNBURY WEST (District No. 46) / ASSOCIATIONDU PARTI LIBÉRAL DE NEW MARYLAND-SUNBURY-OUEST (Circonscription no 46)

Official Representative / Représentante officielle Brigitte Maicher44, croissant Kindle CrescentNasonworth, NB E3C 1M2

10 MIRAMICHI BAY-NEGUAC NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 10) / ASSO-CIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE BAIE-DE-MIRAMICHI-NEGUAC (Circonscription no 10)

President / Président(e) Vacant

_____________________________________________________

PURSUANT TO SUBSECTION 147(2) OF THE ELECTIONS ACTCHAPTER E-3, PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 147(2) DE LA LOI ÉLECTORALECHAPITRE E-3, PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

The following district association of the People’s Alliance of New Brunswick has been registered as provided for in section 135 ofthe Elections Act: / L’association de circonscription de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick suivante a été enregistrée commele prévoit l’article 135 de la Loi électorale :

43 FREDERICTON-FORT NASHWAAK PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK DISTRICT ASSOCIA-TION (District No. 43) / ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DE L’ALLIANCE DES GENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK DE FREDERICTON-FORT NASHWAAK (Circonscription no 43)

President / Président Randall Leavitt363, rue MacPherson StreetFredericton, NB E3A 5H8

Secretary / Secrétaire Jennifer Stackhouse7 Astrid WayFredericton, NB E3C 0H7

Treasurer / Trésorier Jason Inness5-75, rue Vail StreetMoncton, NB E1A 3L2

Official Representative / Représentant officiel Randall Leavitt363, rue MacPherson StreetFredericton, NB E3A 5H8

Page 5: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 683 Gazette royale — 18 avril 2012

RIGHT OF WAY TRANSIT INC. Quispamsis 662490 2012 03 02

Coco Ratté Foresterie Inc. Kedgwick 662595 2012 03 08

Hogan Karz Auto.ca Inc. Moncton 662618 2012 03 09

EHS SAFETY SUPPORT SERVICES INC. Saint John 662793 2012 03 21

Geldart Enterprises Ltd. Turtle Creek 662825 2012 03 22

AGROSTILE INVEST LTD. Saint John 662839 2012 03 22

Real Food Connections Ltd. Fredericton 662840 2012 03 22

JETIX SOLUTIONS LTD. Saint John 662841 2012 03 22

662843 NB INC. Petitcodiac 662843 2012 03 23

GESTION PATRICK FOULEM INC. Caraquet 662844 2012 03 23

GESTION CLARENCE FOULEM INC. Caraquet 662847 2012 03 23

GESTION DENIS FOULEM INC. Dieppe 662848 2012 03 23

LDR Equipment Sales inc. Moncton 662849 2012 03 23

GESTION DAVID JOEL FOULEM INC. Caraquet 662850 2012 03 23

SOCIETE DE GESTION DAVID JOEL FOULEM INC. Dieppe 662851 2012 03 23

INVESTISSEMENTS MEGA CONCEPT INVESTMENTS INC.

Bathurst 662852 2012 03 23

662853 N.B. INC. Dieppe 662853 2012 03 23

662854 N.B. INC. Dieppe 662854 2012 03 23

Squeaky Clean Car Wash Inc. Hanwell 662855 2012 03 23

662857 NB INC. Dieppe 662857 2012 03 23

LINE 10 TREE LINE INC. Bellefond 662863 2012 03 23

662864 NB Inc. Saint John 662864 2012 03 23

Silverwood Stone Corp. Fredericton 662867 2012 03 23

Les Homardiers de Pigeon Hill inc. Pigeon Hill 662868 2012 03 23

662870 N.B. Inc. Saint John 662870 2012 03 23

Ashley Shannon Properties Ltd. Bathurst 662871 2012 03 23

Cintamani Outfitting Canada Inc. Fredericton 662872 2012 03 23

Dr. Kenneth F. Roberts, MD Inc. Fredericton 662877 2012 03 26

HOTEL SHEDIAC INC. Dieppe 662878 2012 03 26

Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer-ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 6: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 684 Gazette royale — 18 avril 2012

Introhive Services Inc. Fredericton 662880 2012 03 26

107 Robinson Street Inc. Moncton 662881 2012 03 26

TradeSource of Canada, Ltd. Moncton 662882 2012 03 26

UNIQUE SHOWERS AND PLUS INC. McLeod 662883 2012 03 26

JMJ Coool Ice Cream Treats Inc. Fredericton 662884 2012 03 26

True North General Contracting Ltd. Pointe à Tom 662889 2012 03 26

Southern Cross Seaplants Inc. Grand Manan 662890 2012 03 26

Guillaume Basque Consultant Ltd. Saint John 662891 2012 03 26

662901 N.B. Ltd. Moncton 662901 2012 03 27

662903 N.B. Ltd. Moncton 662903 2012 03 27

662904 N.B. Ltd. Moncton 662904 2012 03 27

OAKCREEK TRUCKING LTD. Grand Bay-Westfield 662906 2012 03 27

662911 N.-B. INC. Caraquet 662911 2012 03 27

AMBIENCE CONCIERGE INC. Moncton 662912 2012 03 27

PJ ATLANTIC RESTAURANTS (FRED-NORTH) LTD. Lower Coverdale 662913 2012 03 27

662915 N.B. Inc. Dieppe 662915 2012 03 27

Résidence de Patterson Inc. Miramichi 662916 2012 03 27

College of Automotive Service Technicians Inc. Fredericton 662917 2012 03 27

Almirall Limited Saint John 662918 2012 03 27

662921 N.B. INC. Fredericton 662921 2012 03 27

Main Street Veterinary Hospital (2012) Inc. Fredericton 662924 2012 03 27

ARSENO GENERAL CONTRACTORS LTD. Moncton 662926 2012 03 27

662927 N.B. Ltd. Sackville 662927 2012 03 27

JACQUES MELANSON FRAMING INC. Bouctouche Sud / South 662929 2012 03 27

Red Leaf Grill & Lounge Ltd. Moncton 662930 2012 03 27

662932 NB Ltd. Fredericton 662932 2012 03 27

MST HOLDINGS INC. Saint John 662937 2012 03 28

Résidences Austin Inc. Dieppe 662938 2012 03 28

662943 NB Inc. Fredericton 662943 2012 03 28

662945 N.B. Corporation Shediac 662945 2012 03 28

662949 N.B. Inc. Hanwell 662949 2012 03 28

RYJAN Trucking Ltd. Saint-Charles 662950 2012 03 28

MARCO-TANIC VENTURES LTD. Saint John 662953 2012 03 29

SAINT-ANTOINE POUTINE RAPÉE INC. Saint-Antoine 662957 2012 03 29

Simply Living (NB) Inc. Saint John 662958 2012 03 29

GESTION ANDRÉ FOULEM INC. Caraquet 662964 2012 03 29

Nests by Sophie Inc. Dieppe 662965 2012 03 29

Page 7: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 685 Gazette royale — 18 avril 2012

MELANIE MORGAN MUSIC LTD. Shediac 662970 2012 03 29

PÊCHERIES C.F. MÉRIDIEN INC. Sainte-Marie-Saint-Raphaël 662971 2012 03 29

_____________________________________________________

BETTS ENTERPRISES (1983) LTD. 033049 2012 03 29

Maritime Sandblasting and Coatings Ltd. 623920 2012 03 29

640277 NB Inc. 640277 2012 03 26

640277 NB Inc. 640277 2012 03 28

Blackville Building Supplies Ltd. 645163 2012 03 29

646812 NB Ltée 646812 NB Ltd. 646812 2012 03 29

660748 NB Inc. 660748 2012 03 29

Dunn Learning Academy Inc. 662281 2012 03 27

_____________________________________________________

620436 N.B. INC. ARSENO GENERAL CONTRACTORS INC. 620436 2012 03 29

GESTION GLAZER INC. Glazer Tire Inc. 621117 2012 03 28

DIEPPE FRESH CASUAL RESTAURANTS INC.

FRESH CASUAL RESTAURANTS INC. 646282 2012 03 26

FREDERICTON RECYCLING AND REDEMPTION INC.

LOYALIST MECHANICAL CONTRACTING LTD.

651528 2012 03 23

Yorkshire Wind Park GP Inc. Sunrise Trail Wind Park GP Inc. 653792 2012 03 23

_____________________________________________________

053801 N.B. LTEE Nigadoo 053801 2012 03 26

GESTION RÉAL POTVIN INC. Campbellton 056103 2012 03 27

GESTION YANER INC. Campbellton 513755 2012 03 28

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 8: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 686 Gazette royale — 18 avril 2012

Pendlebury Press Limited Saint Andrews 624778 2012 03 28

McCartney Enterprises Inc. Upper Woodstock 630054 2012 03 22

_____________________________________________________

PARK HOUSE INN LTD. Canada 012812 2012 03 21

AllDo Holdings Inc. Colombie-Britannique / British Columbia

646591 2012 03 22

_____________________________________________________

RAE FRASER, LIMITED 006499 2012 03 29

Y & D HOLDINGS LTD 021379 2012 03 27

SEASIDE LANDSCAPING LTD. 049422 2012 03 29

SIGN WORKS LTD. 501066 2012 03 27

VILLAGE CAPITAL CORPORATION 502354 2012 03 21

RIDGEVIEW REALTY LTD. 514136 2012 03 26

608409 N.B. Ltd. 608409 2012 03 22

610664 N.B. Ltd. 610664 2012 03 28

GESTION J. BOURQUE INC. 619289 2012 03 29

FOUR ACES FARM LTD. 619837 2012 03 22

619979 NB LTD. 619979 2012 03 28

642198 N.B. Inc. 642198 2012 03 29

642659 NB Inc. 642659 2012 03 22

_____________________________________________________

Mavome Inc. Canada Michael A. GillisSaint John

662370 2012 03 20

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de cessation a été émis à :

DateJurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

Page 9: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 687 Gazette royale — 18 avril 2012

Cinven Capital Management (V) GeneralPartner Limited

Royaume-Uni /United Kingdom

Arthur T. DoyleSaint John

662760 2012 03 20

PROTECTION POINT SERVICE PLANS INC./REGIMES PROTECTION POINT INC.

Colombie-Britannique /British Columbia

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

662818 2012 03 22

BARN CORPORATION Colorado Daniel L. StevensonFredericton

662835 2012 03 21

Park House Inn Ltd. Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

662886 2012 03 23

MVL Leasing Limited Ontario Charles Robert LynchRothesay

662887 2012 03 26

Dentsply Canada Ltd. Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

662936 2012 03 28

_____________________________________________________

Milliken Design, Inc. SYLVAN CHEMICAL CO., INC. 076716 2012 03 28

_____________________________________________________

Hub International Canada West ULC

Hub International Canada West ULC Deborah M. PowerFredericton

662806 2012 03 21

RASAKTI INC. RASAKTI INC. Peter M. WrightMoncton

662834 2012 03 27

PVH Canada, Inc. TOMMY HILFIGER CANADA RETAIL INC./LES DÉTAILLANTS TOMMY HILFIGER CANADA INC.

Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

662876 2012 03 26

CILOE GROUP INC. CHOICE REEFER SYSTEMS LIMITED

Craig A. WilsonSaint John

662939 2012 03 28

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :

ReferenceNumber Date

Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :

ReferenceAgent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

Page 10: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 688 Gazette royale — 18 avril 2012

Conseil étudiant de l’École de travail social Inc. Moncton 661884 2012 03 27

SUNNY BRAE BAPTIST CHURCH INC. Moncton 662805 2012 03 21

NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF ONSITE WASTEWATER PROFESSIONALS INC./ASSOCIATION DES PROFESSIONELS DES SYSTÈMES AUTONOMES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

Hanwell 662838 2012 03 22

Grand-Sault/Falls, NB Truck and Tractor Pull Association Inc. Grand-Sault / Grand Falls 662922 2012 03 27

_____________________________________________________

New Brunswick Gateway Council Inc. 636770 2012 03 21

_____________________________________________________

CORPORATION D’AMELIORATION DES AFFAIRES DE CAMPBELLTON INC./CAMPBELLTON BUSINESS IMPROVEMENT CORPORATION INC.

023722 2012 03 27

LE CLUB DE L’AGE D’OR DE HAUT-SHEILA INC. 023880 2012 03 22

Watkins Property Management James Robert Watkins Saint John 661982 2012 03 28

The Poker Den Daniel Mongraw Fredericton 662630 2012 03 23

Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,

letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres

patentes ont été émises à :

ReferenceNumber Date

Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,the surrender of charter has been accepted and the company has beendissolved:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, l’abandon dela charte des corporations suivantes a été accepté, et que celles-ci sontdissoutes :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de réference année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the followingcompany is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act:

SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituéeen vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 11: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 689 Gazette royale — 18 avril 2012

Pattes et nageoires Paws and Fins Martin Roy Beresford 662653 2012 03 25

SUNRISE CUSTOM HARVESTING Travis Friesen Summerfield 662674 2012 03 27

Erotic Visions Photography Services Wayne Adshade Moncton 662693 2012 03 27

Fitzpatrick’s Funeral Home FITZPATRICK’S FUNERAL SERVICES LIMITED

Saint John 662769 2012 03 20

Scorpion Trailers PREMIER RECREATION & AUTO SALES LTD.

Quispamsis 662777 2012 03 20

S.H. GALLOP Saeid Aminimagd Moncton 662778 2012 03 20

EXPERT AUTO SERVICES 651240 N.B. LTD. Lakeside 662779 2012 03 20

Grace Foundation THE CHURCH HOME CHARITABLE FOUNDATION INC.

Saint John 662796 2012 03 21

J2 Trucking Glen Elm Farms Inc. Wickham 662801 2012 03 21

Sun Diamond Stables Glen Elm Farms Inc. Wickham 662802 2012 03 21

Back Home Family Campground Keri Hovey Ludlow 662807 2012 03 21

T & W Cleaning Service Tasha Thomas Fredericton 662808 2012 03 21

GSC Industries Boiestown Gwen Davis Fredericton 662824 2012 03 22

Cascade Florale Philippe Paul Sainte-Marie-de-Kent 662826 2012 03 22

GOMOTEL.CA Mario Charlebois Moncton 662828 2012 03 22

Experis Canada MANPOWER SERVICES CANADA LIMITED/SERVICES MANPOWER CANADA LIMITÉE

Saint John 662846 2012 03 23

Doug Hanson Photography Doug Hanson Moncton 662858 2012 03 23

DRIVEN SOLUTIONS Dominion Automobile Association (2004) Limited Automobile Dominion (2004) Limitée

Saint John 662859 2012 03 23

NEGUAC MOTOR SPORTS Gregoire Rousselle Neguac 662860 2012 03 23

Hickeys Used Equipment Donald Hickey Belledune 662861 2012 03 23

Garderie Au Rêve Des Anges Caroline Blier Saint-Jacques 662862 2012 03 23

Norz Asian Groceries & Restaurant Noralyn Baltazar Bathurst 662866 2012 03 23

GREESCAPE CREATIONS Ryan Handrahan Sussex 662869 2012 03 23

Pamela’s Busy Bees Learning Center Pamela Smith-Kennedy Haneytown 662873 2012 03 25

at play Occupational Therapy Stacy McFadden Moncton 662874 2012 03 25

OSCO Concrete OSCO Concrete & Aggregates Limited

Saint John 662875 2012 03 26

Y. Therio Carpentry and Woodwork Yannick Thériault Moncton 662885 2012 03 26

HR ON DEMAND Kevin Murphy Quispamsis 662888 2012 03 26

PICTURE PERFECT CABINETRY & MORE

Nicholas Crouse Woodstock 662892 2012 03 26

BELLA DÉCOR par Nathalie Nathalie Thomas Petit-Rocher 662893 2012 03 26

Hidden Valley Farm Jonathan Holmes Greenfield 662894 2012 03 27

Page 12: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 690 Gazette royale — 18 avril 2012

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMPartnerships and Business Names Registration Act / Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

In relation to the certificate of business name registered on March 23, 2012 under the Act, under the name of “GREESCAPE CREATIONS”, beingfile #662869, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the business name be corrected to read as follows:“GREENSCAPE CREATIONS”.

Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 23 mars 2012 en vertu de la Loi sous le nom de « GREESCAPECREATIONS », dont le numéro d’appellation commerciale est 662869, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, que l’appel-lation commerciale soit corrigée pour qu’elle se lise comme suit : « GREENSCAPE CREATIONS ».

_____________________________________________________

Sports & Therapeutic Massage By David Chesson RMT

David Chesson Beresford 662895 2012 03 27

C. Hunter Industries Christopher Wilson Hunter Fredericton 662896 2012 03 26

Upper Hainesville Springs of Living Water Church

Queensbury Christian Centre, Inc. Nackawic 662898 2012 03 26

DC PATIO PLUS Daniel Chiasson Dieppe 662900 2012 03 27

Senosha Software Sean Simpson Hillsborough 662902 2012 03 27

Moncton Free Press Stephen Downes Moncton 662905 2012 03 27

SEGAL ADVISORS Rogerscasey Canada, Inc. Saint John 662907 2012 03 27

SEGAL ROGERSCASEY Rogerscasey Canada, Inc. Saint John 662908 2012 03 27

ROGERSCASEY CANADA, A SEGAL ADVISORS COMPANY

Rogerscasey Canada, Inc. Saint John 662909 2012 03 27

Dunn’s Towing Lynn Patricia Dunn Rexton 662914 2012 03 27

JPM Janitorial Services Julie Campbell Irishtown 662919 2012 03 27

ROXANNE’S SPECIAL CARE HOME

Roxanne Dorion Picadilly 662920 2012 03 27

FACT FINDING INVESTIGATIONS 662588 NB Inc. Saint-François-de-Madawaska 662923 2012 03 27

AH! CRÈME MOLLE Denis Bossé Saint-Quentin 662925 2012 03 27

Munchie Mundo Austin Vibert Miscou 662931 2012 03 27

Delishables Gourmet Bake Shoppe Natasha Craig Saint John 662934 2012 03 27

La boutique Anadia’s Boutique Denise Gallant Bouctouche 662940 2012 03 28

BAFFLE-FACTION LIQUIDATION Robert Redfurn Saint John 662942 2012 03 28

Duck Duck Bike Alan Derek Barbour Sackville 662944 2012 03 28

Double L Productions Lloyd Cameron Miramichi 662947 2012 03 28

CREEKHOME FARM Henry Helder Salisbury Ouest / West 662948 2012 03 28

J.M. Bird Maple Farm Jamie Bird Burtts Corner 662951 2012 03 28

KJ’s Little Details Karen Jenkins Sussex 662952 2012 03 28

Shotgun Motor Sports David C. Stevenson Old Ridge 662959 2012 03 29

MEADOW LANE RV ESTATES Roger Pickett Jemseg 662963 2012 03 29

Page 13: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 691 Gazette royale — 18 avril 2012

THE DIPLOMAT RESTAURANT KIL INVESTMENTS LTD. Fredericton 327721 2012 03 29

E.W. BLAKNEY & ASSOCIATES Edward Blakney Moncton 328872 2012 03 23

ACADIE-NET ACADIA NET LA FEDERATION DES CAISSES POPULAIRES ACADIENNES LTÉE

Caraquet 340205 2012 03 26

CARRIAGE LANE CHOCOLATES Laurie Yeates New Maryland 340813 2012 03 27

Julie’s Beau-T Stop Julie Morin Clair 348405 2012 03 23

R & W Auto Body Ricky Russell Miramichi 348724 2012 03 27

SIGNS BY CAROLE Donald E. Moore Morrisdale 350158 2012 03 23

Decorative Treasures Jacqueline Purdy Moncton 350907 2012 03 27

Richard Marine Sales and Service Louis Richard Richibouctou Village 350943 2012 03 26

J R Masonry Emmett Henry Fredericton 351159 2012 03 21

HAPPY ISLAND ATV TOURS David J. Sherwood Islandview 353283 2012 03 23

FIRST CHOICE HAIRCUTTERS First Choice Haircutters Ltd. Saint John 353524 2012 03 21

MAGICUTS MAGICUTS ZEE INC. Saint John 353525 2012 03 21

SMARTSTYLE REGIS HAIRSTYLISTS, LTD. Saint John 353527 2012 03 21

REGIS SALON REGIS HAIRSTYLISTS, LTD. Saint John 353528 2012 03 21

SMARTSTYLE MAGICUTS ZEE INC. Saint John 353530 2012 03 21

GCR CENTRES DE PNEUS BRIDGESTONE CANADA INC. Saint John 600352 2012 03 23

TSX MARKETS TSX INC. Saint John 601437 2012 03 26

TSX VENTURE EXCHANGE TSX INC. Saint John 601439 2012 03 26

TORONTO STOCK EXCHANGE TSX INC. Saint John 601440 2012 03 26

TSX VENTURE EXCHANGE TSX VENTURE EXCHANGE INC. BOURSE DE CROISSANCE TSX INC.

Saint John 601441 2012 03 26

Le Nicho A.F.G. VENTILATION ET CHAUFFAGE LTÉE

Val-Comeau 629060 2012 03 27

DanJo Cleaning Products & Supplies Maurice Cormier Notre-Dame 629486 2012 03 27

LITEMOR HD Supply Canada Inc. Moncton 629775 2012 03 28

MARINER’S REACH 625841 N.B. Inc. Beaver Harbour 629897 2012 03 20

HD Supply HD Supply Canada Inc. Moncton 629941 2012 03 28

HD Supply Canada HD Supply Canada Inc. Moncton 629942 2012 03 28

HD Supply Facilities Maintenance HD Supply Canada Inc. Moncton 629943 2012 03 28

Litemor Distributors HD Supply Canada Inc. Moncton 629945 2012 03 28

HD Supply Electrical HD Supply Canada Inc. Moncton 629946 2012 03 28

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 14: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 692 Gazette royale — 18 avril 2012

HD Supply Utilities HD Supply Canada Inc. Moncton 629948 2012 03 28

Grafton Utility Supply HD Supply Canada Inc. Moncton 629949 2012 03 28

Grafton West HD Supply Canada Inc. Moncton 629950 2012 03 28

Brafasco HD Supply Canada Inc. Moncton 629951 2012 03 28

HD Supply Fasteners & Tools HD Supply Canada Inc. Moncton 629952 2012 03 28

Grafton Utility Supply (Western) HD Supply Canada Inc. Moncton 629953 2012 03 28

Seawind Buffalo Ranch 629489 NB INC. Sainte-Anne-de-Kent 630098 2012 03 22

Opti Tech Services Yvon Chiasson DSL de / LSD of Drummond 630107 2012 03 27

THE DIP KIL INVESTMENTS LTD. Fredericton 630172 2012 03 29

DIPLOMAT EGG ROLLS KIL INVESTMENTS LTD. Fredericton 630173 2012 03 29

DIPLOMAT FOODS KIL INVESTMENTS LTD. Fredericton 630174 2012 03 29

Saigon Thai Restaurant SAIGON THAI LTD. Moncton 630219 2012 03 28

ARSENEAULT & PELLETIER, AVOCATS

RENÉ ARSENEAULT C.P. INC. Balmoral 630243 2012 03 26

Couture Builders & Renovators Michael Joseph Couture Bathurst 630316 2012 03 22

Onglerie D’vine Nails Angèle Bertin Beresford 630348 2012 03 23

Stuart’s Electric Stuart Augot Rusagonis 630383 2012 03 28

Cynetik Philippe Duclos Moncton 630454 2012 03 24

BUTLAND’S SEAFOOD 058223 N.B. LTD. Alma 631434 2012 03 27

_____________________________________________________

ABN AMRO LEASING Saint John 600058 2012 03 27

ABN AMRO BANK N.V., Canada Branch Saint John 600060 2012 03 27

TSX GROUP Saint John 601436 2012 03 26

TSX DATALINX Saint John 601438 2012 03 26

RÉSIDENCE AUSTIN ENRG. Dieppe 611613 2012 03 28

COCO RATTÉ FORESTERIE Kedgwick 650820 2012 03 26

EXPERT AUTO SERVICES Saint John 651918 2012 03 20

JMJ Coool Ice Cream Treats Fredericton 658181 2012 03 26

Geldart Enterprises Turtle Creek 662676 2012 03 22

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Page 15: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 693 Gazette royale — 18 avril 2012

Gammon Farms Hamilton GammonBernice GammonEllen Gammon

Bathurst 662837 2012 03 22

Get Bubbled Waterball Ride Dwight R. StairsKari A. Stairs

Durham Bridge 662879 2012 03 26

THE PLAYDATES Adam WilliamsonChris ClaessenAaron KyleChris Reicker

Saint John 662928 2012 03 27

_____________________________________________________

SALON ELITE Daphne Louise WilliamsDonna Susan Savoy

St. George 630197 2012 03 26

Arthur J. Gallagher (Canada) Group AJG North America ULCAJG Canada ULC

Saint John 630326 2012 03 22

_____________________________________________________

GARDERIE “AU RÊVE DES ANGES” Saint-Jacques 618943 2012 03 23

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement de société en nom collectif a été enregistré :

Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Datecommerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Page 16: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 694 Gazette royale — 18 avril 2012

JMMR PELLETIER FARMS Jean-Marie Pelletier Bald Peak View Farms Inc.

644284 2012 03 21

Carter Camp, LP. Fredericton Washington Daniel L. StevensonFredericton

625952 2012 03 22

Cinven Capital Management (V) Limited Partnership Incorporated

Saint John Royaume-Uni / United Kingdom

Arthur T. DoyleSaint John

662761 2012 03 20

Fifth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership

Saint John Royaume-Uni / United Kingdom

Arthur T. DoyleSaint John

662763 2012 03 20

Fifth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership

Saint John Royaume-Uni / United Kingdom

Arthur T. DoyleSaint John

662764 2012 03 20

Fifth Cinven Fund (No. 3) Limited Partnership

Saint John Royaume-Uni / United Kingdom

Arthur T. DoyleSaint John

662765 2012 03 20

Fifth Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership

Saint John Royaume-Uni / United Kingdom

Arthur T. DoyleSaint John

662767 2012 03 20

Fifth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership

Saint John Royaume-Uni / United Kingdom

Arthur T. DoyleSaint John

662768 2012 03 20

Amaranthine Resources LTD. Kedgwick Colorado Daniel L. StevensonFredericton

662836 2012 03 22

CBS OUTDOOR CANADA LP Saint John Ontario Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

662845 2012 03 23

Brompton 2012 Flow-Through Limited Partnership

Saint John Ontario Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John

662935 2012 03 28

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of member-ship of partnership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Retiring Partners Incoming Partners Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Associés sortants Nouveaux associés référence année mois jour

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership hasbeen filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-sée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Agent and Address Number DatePrincipal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

Page 17: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 695 Gazette royale — 18 avril 2012

AlphaNorth 2010 Flow-Through Limited Partnership

Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

649028 2012 03 23

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limitedpartnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale aété déposée par :

ReferenceAgent and Address Number Date

Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour

Association of New BrunswickLicensed Practical Nurses

NOTICE OF EXAMINATIONThe Registration Examination for Practical Nurses will be heldin Fredericton, N.B. on Wednesday, May 16, 2012.The Examination will be conducted by the Association of NewBrunswick Licensed Practical Nurses. Enquiries should be ad-dressed to:

The Registrar, ANBLPN384 Smythe StreetFredericton, N.B. E3B 3E4

SALE OF MOTOR VEHICLESTake notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province ofNew Brunswick, will be disposing of the following vehicles onor after April 18, 2012:

1998, Volks JettaSerial No. 3VWRA81HXWM117563License Plate: GDE241Registered Owner: Jason K. ScribnerVehicle located at CMV Towing Ltd, Quispamsis

2001, Chev CavalierSerial No. 3G1JF12T11S215955License Plate: GMB915Registered Owner: Michael S. CromwellVehicle located at CMV Towing Ltd, Quispamsis

1998, Pontiac SunfireSerial No. 1G2JB5245W7518590License Plate: BWB021Registered Owner: Michelle E. GivenVehicle located at CMV Towing Ltd, Quispamsis

Notices

Department ofPublic Safety

L’Association des Infirmier(ère)sAuxiliaires Autorisé(e)s du Nouveau-Brunswick

AVIS D’EXAMENL’inscription de l’examen des infirmier(ère)s auxiliaires auralieu à Fredericton (N.-B.) le mercredi 16 mai 2012.L’examen sera administré par l’Association des infirmier(ère)sauxiliaires autorisé(e)s du Nouveau-Brunswick. Pour des de-mandes de renseignements s’adresser à :

Registraire, AIAANB384, rue SmytheFredericton (N.-B.) E3B 3E4

VENTE DE VÉHICULES À MOTEURSachez que le registraire des véhicules à moteur de la provincedu Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteursuivants le 18 avril 2012 :

Volks Jetta 1998Numéro de série : 3VWRA81HXWM117563Numéro d’immatriculation : GDE241Propriétaire immatriculé : Jason K. ScribnerVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing Ltd,QuispamsisChev Cavalier 2001Numéro de série : 3G1JF12T11S215955Numéro d’immatriculation : GMB915Propriétaire immatriculé : Michael S. CromwellVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing Ltd,QuispamsisPontiac Sunfire 1998Numéro de série : 1G2JB5245W7518590Numéro d’immatriculation : BWB021Propriétaire immatriculée : Michelle E. GivenVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing Ltd,Quispamsis

Avis

Ministère de laSécurité publique

Page 18: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 696 Gazette royale — 18 avril 2012

Pontiac Grand Prix 1997Numéro de série : 1G2WJ52K8VF249416Numéro d’immatriculation : BJW837Propriétaire immatriculé : Darren F. YoungVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing Ltd,QuispamsisOlds Alero 2000Numéro de série : 1G3NK12T7YC415680Numéro d’immatriculation : GBY281Propriétaire immatriculé : Ernest M. ForsytheVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing Ltd,QuispamsisChrysler Intrepid 1999Numéro de série : 2C3HH46R7XH715988Numéro d’immatriculation : BZF309Propriétaire immatriculée : Kelly Dawn FerraraVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing Ltd,QuispamsisChev Cavalier 1997Numéro de série : 3G1JC5244VS857861Numéro d’immatriculation : GKP249Propriétaire immatriculée : Dawn Marie ObalVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing Ltd,QuispamsisBuick Park Avenue 1997Numéro de série : 1G4CW52K7V4610948Numéro d’immatriculation : BVH206Propriétaire immatriculée : Amy M. PattersonVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing Ltd,QuispamsisDodge Grand Caravan 2001Numéro de série : 2B4GP44R01R127247Numéro d’immatriculation : GHO753Propriétaire immatriculé : Jesse FloydVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing Ltd,QuispamsisKia Spectra 2003Numéro de série : KNAFB121635217282Numéro d’immatriculation : JAT442Propriétaire immatriculé : Nick RobertsonNick Robertson Auto SalesVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing Ltd,QuispamsisInfinity QX4 2001Numéro de série : JNRDR09Y71W210092Numéro d’immatriculation : CKP064Propriétaire immatriculé : Nick RobertsonNick Robertson Auto SalesVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing Ltd,Quispamsis

1997, Pontiac Grand PrixSerial No. 1G2WJ52K8VF249416License Plate: BJW837Registered Owner: Darren F. YoungVehicle located at CMV Towing Ltd, Quispamsis

2000, Olds AleroSerial No. 1G3NK12T7YC415680License Plate: GBY281Registered Owner: Ernest M. ForsytheVehicle located at CMV Towing Ltd, Quispamsis

1999, Chrysler IntrepidSerial No. 2C3HH46R7XH715988License Plate: BZF309Registered Owner: Kelly Dawn FerraraVehicle located at CMV Towing Ltd, Quispamsis

1997, Chev CavalierSerial No. 3G1JC5244VS857861License Plate: GKP249Registered Owner: Dawn Marie ObalVehicle located at CMV Towing Ltd, Quispamsis

1997, Buick Park AvenueSerial No. 1G4CW52K7V4610948License Plate: BVH206Registered Owner: Amy M. PattersonVehicle located at CMV Towing Ltd, Quispamsis

2001, Dodge Grand CaravanSerial No. 2B4GP44R01R127247License Plate: GHO753Registered Owner: Jesse FloydVehicle located at CMV Towing Ltd, Quispamsis

2003, Kia SpectraSerial No. KNAFB121635217282License Plate: JAT442Registered Owner: Nick RobertsonNick Robertson Auto SalesVehicle located at CMV Towing Ltd, Quispamsis

2001, Infinity QX4Serial No. JNRDR09Y71W210092License Plate: CKP064Registered Owner: Nick RobertsonNick Robertson Auto SalesVehicle located at CMV Towing Ltd, Quispamsis

Page 19: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 697 Gazette royale — 18 avril 2012

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Edward Francis Lockyer, original Mortgagor; and to all oth-ers whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mort-gage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts inamendment thereof. Freehold property being situated at 129,131, 133 Crerar Court, Fredericton, New Brunswick, the samelot conveyed to Edward Francis Lockyer by Transfer registeredin the Land Titles Office on March 30, 2005 as document num-ber 20041175.

Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank as Mort-gagee. Sale to be held at the Fredericton Court House located at427 Queen Street, Fredericton, New Brunswick on the 26th dayof April, 2012, at the hour of 11:00 a.m., local time. See adver-tisement of Notice of Mortgage Sale in The Daily Gleaner datedMarch 29, April 5, April 12 and April 19, 2012.

McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,Per: T. Ryan Seymour, Barker House, Suite 600, 570 QueenStreet, P.O. Box 610, Station A, Fredericton, New Brunswick,E3B 5A6, Telephone: 506-458-8572, Facsimile: 506-458-9903

________________

To: Tony Norman Parker, of Letang, in the County of Charlotteand Province of New Brunswick, Mortgagor;

And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 54 Limekiln Roadin the County of Charlotte and Province of New Brunswick,PID #15068315.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 16th day of May, 2012, at 11:00 a.m., at the TownHall in St. Stephen, 73 Milltown Boulevard, St. Stephen, NewBrunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or re-schedule the time and date of sale. See advertisement inThe Saint Croix Courier.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada

________________

To: Joseph Clarence Hebert and Donna Lee Hebert, of the Cityof Dieppe, in the County of Westmorland and Province of NewBrunswick, Mortgagors;And to: Citifinancial Canada East Corporation, 185 AcadieAvenue, Dieppe, New Brunswick, E1A 1G6, 2nd Mortgagee;

And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 1050-1054Chartersville Road, in the City of Dieppe, in the County ofWestmorland and Province of New Brunswick, PID Number00926154.

Notices of Sale

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Destinataire : Edward Francis Lockyer, débiteur hypothécaireoriginaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuéeconformément aux dispositions de l’acte d’hypothèque et decelles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens entenure libre situés aux 129, 131 et 133, cour Crerar, Fredericton(Nouveau-Brunswick) correspondant au même lot ayant ététransféré à Edward Francis Lockyer par l’acte de transfert enre-gistré au bureau de l’enregistrement foncier le 30 mars 2005sous le numéro 20041175.Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 26 avril 2012, à 11 h,heure locale, au palais de justice de Fredericton, situé au427, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick). Voir l’an-nonce publiée dans les éditions du 29 mars et des 5, 12 et19 avril 2012.

T. Ryan Seymour, du cabinet McInnes Cooper, avocats de LaBanque Toronto-Dominion, Barker House, bureau 600,570, rue Queen, C.P. 610, succursale A, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5A6; téléphone : 506-458-8572; télécopieur :506-458-9903

________________

Destinataire : Tony Norman Parker, de Letang, comté deCharlotte, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothé-caire;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 54, chemin Limekiln, comté deCharlotte, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est15068315.Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 16 mai 2012, à 11 h, à l’hôtel de ville deSt. Stephen, 73, boulevard Milltown, St. Stephen (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans The Saint Croix Courier.

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada

________________

Destinataires : Joseph Clarence Hebert et Donna Lee Hebert, dela ville de Dieppe, comté de Westmorland, province duNouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires;CitiFinancière, corporation du Canada Est, 185, avenue del’Acadie, Dieppe (Nouveau-Brunswick) E1A 1G6, deuxièmecréancière hypothécaire;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés aux 1050-1054, cheminChartersville, ville de Dieppe, comté de Westmorland, provincedu Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 00926154.

Avis de vente

Page 20: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 698 Gazette royale — 18 avril 2012

Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 23rd day of May, 2012, at 11:00 a.m., in the lobby ofthe Moncton City Hall, 655 Main Street, Moncton, NewBrunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or re-schedule the time and date of sale. See advertisement in theTimes & Transcript.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada

The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette Coordinator, in the Queen’sPrinter Office, no later than noon, at least seven days prior toWednesday’s publication. Each document must be separatefrom the covering letter. Signatures on documents must be im-mediately followed by the printed name. The Queen’s Printermay refuse to publish a document if any part of it is illegible,and may delay publication of any document for administrativereasons.Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:

NoticesCost perInsertion

Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill

$ 20

Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,

1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30Any document under the Political Process Financing Act $ 20

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act

$ 20

Notice under the Quieting of Titles Act (Form 70B)Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

$120

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)

$ 20

Notice of a correction charge isthe same as

for publishing the original document

Any other document $3.50 for each cm or less

Notice to Advertisers

Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 23 mai 2012, à 11 h, dans le foyer de l’hôtelde ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans le Times & Transcript.

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, à midi, aumoins sept jours avant le mercredi de publication. Chaqueavis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signa-taires doivent suivre immédiatement la signature. L’Impri-meur de la Reine peut refuser de publier un avis dont une par-tie est illisible et retarder la publication d’un avis pour desraisons administratives.Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :

AvisCoût par parution

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le

financement de l’activité politique20 $

Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions

20 $

Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété(Formule 70B)

Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 posur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur

20 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés

pour la publication du

document original

Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou

moins

Avis aux annonceurs

Page 21: The Royal Gazette / Gazette royale (12/04/18) · The Royal Gazette — April 18, 2012 682 Gazette royale — 18 avril 2012 Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3,

The Royal Gazette — April 18, 2012 699 Gazette royale — 18 avril 2012

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.

The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/attorney general/royal gazette.html

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe Office of the Queen’s Printer, at $4.00 per copy plus 13%tax, plus shipping and handling where applicable.

Office of the Queen’s Printer670 King Street, Room 117

P.O. Box 6000Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-2520 Fax: 506-457-7899E-mail: [email protected]

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établià l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur general/gazette royale.html

Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, pour la sommede 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 13 %, ainsi que les fraisapplicables de port et de manutention.

Bureau de l’Imprimeur de la Reine670, rue King, pièce 117

C.P. 6000Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1Tél. : 506-453-2520 Téléc. : 506-457-7899

Courriel : [email protected]

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés