The Royal Gazette / Gazette royale (11/05/18) - New Brunswick · The Royal Gazette Fredericton New...

30
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Vol. 169 Wednesday, May 18, 2011 / Le mercredi 18 mai 2011 597 ISSN 1714-9428 Notice to Readers The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least 7 working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator at 453-8372. APRIL 7, 2011 2011-112 Under paragraph 2(1)(b) and subsections 2(2) and 3(2) of the Labour and Employment Board Act, the Lieutenant-Governor in Council (a) reappoints Brian D. Bruce, Q.C., Fredericton, New Brunswick, as a Vice-Chairperson of the Labour and Em- ployment Board, for a term of three years, effective April 12, 2011; (b) appoints Donald MacLean, Shediac, New Brunswick, as a Vice-Chairperson of the Labour and Employment Board, for a term of three years, effective April 7, 2011; Orders in Council Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à la coordonna- trice de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou- vrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale au 453-8372. LE 7 AVRIL 2011 2011-112 En vertu de l’alinéa 2(1)b) et des paragraphes 2(2) et 3(2) de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi, le lieutenant- gouverneur en conseil : a) nomme pour un nouveau mandat Brian D. Bruce, c.r., de Fredericton (Nouveau-Brunswick), vice-président de la Commission du travail et de l’emploi, pour un mandat de trois ans, à compter du 12 avril 2011; b) nomme Donald MacLean, de Shediac (Nouveau- Brunswick), vice-président de la Commission du travail et de l’emploi, pour un mandat de trois ans, à compter du 7 avril 2011; Décrets en conseil

Transcript of The Royal Gazette / Gazette royale (11/05/18) - New Brunswick · The Royal Gazette Fredericton New...

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Vol. 169 Wednesday, May 18, 2011 / Le mercredi 18 mai 2011 597

ISSN 1714-9428

Notice to Readers

The Royal Gazette is officially published on-line.

Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.

Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least7 working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe Royal Gazette Coordinator at 453-8372.

APRIL 7, 20112011-112

Under paragraph 2(1)(b) and subsections 2(2) and 3(2) of theLabour and Employment Board Act, the Lieutenant-Governorin Council

(a) reappoints Brian D. Bruce, Q.C., Fredericton, NewBrunswick, as a Vice-Chairperson of the Labour and Em-ployment Board, for a term of three years, effective April 12,2011;(b) appoints Donald MacLean, Shediac, New Brunswick, asa Vice-Chairperson of the Labour and Employment Board,for a term of three years, effective April 7, 2011;

Orders in Council

Avis aux lecteurs

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.

Les documents à publier doivent parvenir à la coordonna-trice de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou-vrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de laGazette royale au 453-8372.

LE 7 AVRIL 20112011-112

En vertu de l’alinéa 2(1)b) et des paragraphes 2(2) et 3(2) de laLoi sur la Commission du travail et de l’emploi, le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) nomme pour un nouveau mandat Brian D. Bruce, c.r., deFredericton (Nouveau-Brunswick), vice-président de laCommission du travail et de l’emploi, pour un mandat detrois ans, à compter du 12 avril 2011;b) nomme Donald MacLean, de Shediac (Nouveau-Brunswick), vice-président de la Commission du travail etde l’emploi, pour un mandat de trois ans, à compter du 7 avril2011;

Décrets en conseil

The Royal Gazette — May 18, 2011 598 Gazette royale — 18 mai 2011

(c) designates current Vice-Chairperson, Geoffrey Bladon,as the Alternate Chairperson of the Labour and EmploymentBoard, effective April 7, 2011.

Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor

________________

APRIL 7, 20112011-113

Under paragraph 2(1)(c) and subsection 3(2) of the Labour andEmployment Board Act, the Lieutenant-Governor in Councilappoints or reappoints, as the case may be, the following per-sons as members of the Labour and Employment Board, for aterm of three years, effective April 7, 2011:

(a) appoints Marie-Ange Losier, Beresford, NewBrunswick, as a representative of employees;(b) reappoints Gloria Clark, Saint John, New Brunswick, asa representative of employers;

(c) reappoints Stephen Beatteay, Saint John, NewBrunswick, as a representative of employers; and

(d) reappoints Bob Sleva, Blacks Harbour, New Brunswick,as a representative of employers.

Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor

________________

APRIL 7, 20112011-114

Under section 3 of the Agricultural Operation Practices Act, theLieutenant-Governor in Council reappoints Dolorès Poirier,Shediac-Bridge, New Brunswick, as a member of the FarmPractices Review Board who does not carry on an agriculturaloperation, for a term of three years, effective April 7, 2011.

Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor

________________

APRIL 14, 20112011-121

Under subsection 10(3) of the Human Rights Act, theLieutenant-Governor in Council reappoints the following per-sons as members of the New Brunswick Human Rights Com-mission, for a term of three years, effective May 14, 2011:

(a) Emil T. Olsen, Quispamsis, New Brunswick; and(b) René Landry, Moncton, New Brunswick.

Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor

________________

c) désigne le vice-président actuel, Geoffrey Bladon, pré-sident suppléant de la Commission du travail et de l’emploi,à compter du 7 avril 2011.

Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas

________________

LE 7 AVRIL 20112011-113

En vertu de l’alinéa 2(1)c) et du paragraphe 3(2) de la Loi sur laCommission du travail et de l’emploi, le lieutenant-gouverneuren conseil nomme ou nomme pour un nouveau mandat, selon lecas, les personnes suivantes membres de la Commission du tra-vail et de l’emploi, pour un mandat de trois ans, à compter du7 avril 2011 :

a) nomme Marie-Ange Losier, de Beresford (Nouveau-Brunswick), à titre de représentante des employés;b) nomme pour un nouveau mandat Gloria Clark, de SaintJohn (Nouveau-Brunswick), à titre de représentante des em-ployeurs;c) nomme pour un nouveau mandat Stephen Beatteay, deSaint John (Nouveau-Brunswick), à titre de représentant desemployeurs; etd) nomme pour un nouveau mandat Bob Sleva, de BlacksHarbour (Nouveau-Brunswick), à titre de représentant desemployeurs.

Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas

________________

LE 7 AVRIL 20112011-114

En vertu de l’article 3 de la Loi sur les pratiques relatives auxopérations agricoles, le lieutenant-gouverneur en conseilnomme pour un nouveau mandat Dolorès Poirier, de ShediacBridge (Nouveau-Brunswick), membre de la Commission derévision des pratiques agricoles, à titre de membre n’exerçantaucune activité agricole, pour un mandat de trois ans, à compterdu 7 avril 2011.

Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas

________________

LE 14 AVRIL 20112011-121

En vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur les droits de la per-sonne, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nou-veau mandat les personnes suivantes membres de la Commis-sion des droits de la personne, pour un mandat de trois ans, àcompter du 14 mai 2011 :

a) Emil T. Olsen, de Quispamsis (Nouveau-Brunswick); etb) René Landry, de Moncton (Nouveau-Brunswick).

Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas

________________

The Royal Gazette — May 18, 2011 599 Gazette royale — 18 mai 2011

APRIL 28, 20112011-124

Under subsection 2(3) of the Sheriffs Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Larry Williams of the Town ofRiverview, as Deputy Sheriff for the Province of NewBrunswick, effective April 28, 2011.Under subsection 2(1) of the Sheriffs Act and section 26 of theInterpretation Act, the Lieutenant-Governor in Council revokesOrder in Council 2009-527 dated December 10, 2009.

Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor

NOTICE OF LEGISLATIONTake Notice that the Cosmetology Association of NewBrunswick intends to apply to the Legislative Assembly for anamendment to the Cosmetology Act. The object of the amendments are to clarify who may be granteda license to practice cosmetology by the Cosmetology Associa-tion of New Brunswick. The amendments also address certainhousekeeping items in the legislation.

Douglas Black, President, Cosmetology Association of NewBrunswick, 220 Whiting Road, Fredericton, NB E3B 5V5

Legislative Assembly

LE 28 AVRIL 20112011-124

En vertu du paragraphe 2(3) de la Loi sur les shérifs, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme Larry Williams, de laville de Riverview, shérif adjoint pour la province du Nouveau-Brunswick, à compter du 28 avril 2011.En vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur les shérifs et de l’ar-ticle 26 de la Loi d’interprétation, le lieutenant-gouverneur enconseil révoque le décret en conseil 2009-527, pris le 10 dé-cembre 2009.

Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas

AVIS DE PROJET DE LOISachez que l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick a l’intention de solliciter la modification de la Loisur la cosmétologie auprès de l’Assemblée législative.Cette modification a pour but de clarifier qui peut obtenir unpermis de l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick pour pratiquer la cosmétologie. Elle vise égalementcertaines questions d’ordre administratif qui figurent dans lesdispositions législatives.

Douglas Black, Président, Association de cosmétologie duNouveau-Brunswick, 220, chemin Whiting, Fredericton (N.-B.)E3B 5V5

Assemblée législative

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provincialeset d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovin-ciales

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provincialesSachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporationscommerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations suivan-tes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corporationsont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou docu-ments requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la pu-blication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourradissoudre lesdites corporations.

Loi sur les corporationscommerciales

Notice of a decision to dissolve provincial corporations and tocancel the registration of extra-provincial corporations

Notice of decision to dissolve provincial corporationsTake notice that the Director under the Business Corporations Act hasmade a decision to dissolve the following corporations pursuant toparagraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been indefault in sending to the Director fees, notices, and/or documents re-quired by the Act. Please note that 60 days after the date of publicationof this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve thecorporations.

Business Corporations Act

639144 (TVI) Titan Ventures International Inc.000720 000720 N.B. INC.033883 033883 N.B. LTD.035688 035688 NB Inc.039687 039687 N. B. LTD.047761 047761 N. B. LTD.054334 054334 N.B. LTD054428 054428 N.B. LTD.057228 057228 NB LTEE057901 057901 N.B INC.059894 059894 N.-B. LTEE644966 1Pivot Corp.

500161 500161 N.B. LTD.500217 500217 N.B. LTD.505057 505057 N.B. INC.507086 507086 NB LTD.507202 507202 N.B. Ltd.507249 507249 N.B. LTD.507258 507258 N.B. Ltd.508832 508832 N.B. LTD.508834 508834 N.B. Ltd.509472 509472 N.B. LTD.509615 509615 N.B. INC.509643 509643 N.B. Inc.

509644 509644 N.B. Inc.509645 509645 N.B. Inc.509646 509646 N.B. Inc.509647 509647 N.B. Inc.509731 509731 (N.B.) LTD.511996 511996 NB LTD.512232 512232 N.B. LTD.514647 514647 N.B. Ltd.514713 514713 N.B. INC.601908 515331 N. B. INC.601405 601405 N.B. LTD.601545 601545 N.B. LTD.

The Royal Gazette — May 18, 2011 600 Gazette royale — 18 mai 2011

601748 601748 N.B. Ltd.601782 601782 NB LTD.601849 601849 N.B. INC.607378 607378 N.B. INC.612925 612925 N.B. LTD.612967 612967 N.B. Ltd.613010 613010 N. B. LTD.613194 613194 N.B. Limited/ 613194 N.-B.

Limitée613241 613241 N.B. Inc.619267 619267 N.B. Inc.619344 619344 N.-B. Ltée619425 619425 N.-B. INC.619534 619534 N.B. Inc.619575 619575 N.B. LTD.619645 619645 NB LTD.619748 619748 New Brunswick Inc.619818 619818 N.B. INC.625933 625933 N.B. LTD.625976 625976 N.B. Ltd.626061 626061 N.B. Inc.626087 626087 NB Limited632355 632355 N.B. INC.632372 632372 N.B. Inc.632422 632422 N.B. LTD.632527 632527 New Brunswick Inc.632706 632706 New Brunswick Inc.638642 638642 N.-B. INC.638715 638715 N.-B. INC.638864 638864 NB Inc.638948 638948 NB Inc.638999 638999 N.-B. INC.639051 639051 NB Ltd.639056 639056 N.B. Inc.639111 639111 N.B. LTD.645007 645007 N.-B. INC.645044 645044 N.B. LTD.645068 645068 N.B. Inc.645071 645071 N.B. Inc.645147 645147 N.B. LTD.645178 645178 NB Inc.645192 645192 NB Inc.645241 645241 NB Inc.645253 645253 N.B. INC.645288 645288 NB INC.645296 645296 NB Ltd.645302 645302 NB Inc.645381 645381 N.B. INC.645397 645397 NB Inc.645400 645400 NB Inc.645413 645413 N.B. LTD.645417 645417 NB Inc.645441 645441 NB Ltd.645462 645462 NB INC.645493 645493 N.-B. Inc.645508 645508 N.B. LTD.645515 645515 NB Ltd.626088 A & J McNutt Real Estate Holdings Inc.057868 A & T PORTERING LTD.010973 A. & R. MILLER CONTRACTORS LTD.626497 A. L. ROSS ENTERPRISES INC.507087 A.L.M. & FILS ENTREPRENEUR LTÉE619835 A.R. Emberley Electric Ltd.613226 Acadie-Broue Inc.512239 ACROLECT INTERNATIONAL INC.601818 Active Physiotherapy Clinic Professional

Corporation052252 ADRIEN MELANSON CORPORATION

PROFESSIONNELLE LTEE057940 AGT LUMBER LTD.638747 airflow innovations corp.047661 ALL CARPENTRY NEEDS LTD.625975 All Lift Warehouse Systems Inc.054375 ALLAIN DRYWALL LTD.638757 ALLTECH METAL SOLUTIONS INC.645497 ALMOND360 Inc.500397 AMBASSADOR DUTY FREE

MANAGEMENT SERVICES LIMITED

626151 AMES TAPING TOOLS OF CANADA LIMITED

607136 ANNUAIRE M.N.B. DIRECTORY INC.045267 ANTHONY’S CARPENTER SHOP

LTD.037499 AQUA PURA SALMON LTD.509671 ASM Manufacturing Inc.607157 ASTLE TIRE & BODY SHOP LTD.607447 ATLANTIC DISCOUNT IMPORT

PARTS LTD.645029 Atlantic Sealers Inc.505082 AUBERGE BELCOURT INN LIMITED645193 Auxilium Canada Ltd.625912 B & D Holdings Inc.505015 B. P. & SONS RENV. INC.049397 B. WISE INC.057967 BEAR INVESTMENTS INC.502597 BEECHWOOD MOTEL LTD.626092 Belts And Beyond Inc.626307 Beresford Pre-Owned Auto Ltd.500313 BERRYMAN INVESTMENTS INC.632281 Big Yellow House Inc.001919 BIJOUTERIE LANDRY LIMITEE613383 Bill’s Welding and Fabrication Ltd.626363 BIO-D ÉNERGIE INC.619322 BLOOD COLLECTORS INC.645027 Blue Moon Enterprises Contracting Inc.502671 BLUE MOON MOTEL LTD.002070 BONDED BUILDERS CO. LTD.042036 BORDER INVESTMENTS INC.057993 BOUCTOUCHE SELF STORAGE INC.638751 BOUDREAU MEAT MARKET INC.052164 BRANSCOMBE’S FOUNDRY, LTD.645320 Brick Campaign Inc.507152 BROWN’S VENDING INC.500382 BRUNSWICK HOME CARE LTD.035673 BURTON EQUIPMENT RENTAL &

TRUCKING LTD.000389 C. KALE HOLDINGS LTD.626387 Cachal Property Investments Inc.645483 Callstar Telemarketing Ltd.002807 CAMERON LEASEHOLDS LTD.601556 CAPT. TERRY’S AT THE WHARF INC.512217 CARLETON YORK TRUCKERS

ASSOCIATION INC.057291 CASCO BAY AQUACULTURE LTD.003266 CENTRAL KINGS RECREATIONAL

COUNCIL LIMITED512254 CENTRE FOR SPEED INC.632602 CENTURY 21 FIRST RATE REALTY

LTD.626493 CG Investments (2006) Inc.645219 CHEVIE INVESTMENTS INC.003588 CHEVO HOLDINGS LTD.644974 Chickenomics Inc.619765 CHICO ENSEIGNES XPRESS INC./

CHICO XPRESS SIGNS INC.607443 CHRISTIAN C.J. TRUCKING LTD.509523 CHUMLEY’S EATERY LTD.638981 CJet Holdings Ltd.645179 Cleantopia Laundromat Ltd.645440 Coppley Corp.512146 Cormier Mécanique Plus Ltée626281 CORORA PROPERTIES INC.645328 Corporation Professionnelle Dre

Stéphanie Melanson601719 Corporation Professionnelle Médicale

Thériault Arsenault Ltée607474 Cory Guimond Holdings Inc.030524 COURTENAY TRAILER RENTALS

LTD.619449 CROSSWIND PROPERTIES, INC.004546 CRYSTAL ESTATES LIMITED619358 Curtis Ventures Inc.500298 CYBER SOLUTIONS LTD.626247 D.L. NEWMAN TRANSPORT INC.645439 Davidson Appliance & Air Conditioning

Services Ltd.

638855 DAYBREAK SENIOR ACTIVITY CENTRES LTD.

514653 Decoma Holdings Ltd.507140 DENCO LOGGING LTD.601548 Deschenes Trucking Inc.004970 DEWARE ENTERPRISES

(SACKVILLE) LTD.612884 Dez Medical Supplies Company Limited639164 DI Holdings Ltd.004980 DIAMOND AUTO SALES LIMITED645256 Dieppe Commandos Hockey Club Inc.005083 DOFRED DEVELOPERS LIMITED005089 DOHERTY WELL DRILLING LTD005096 DOIRON STATION-SERVICE LTEE005157 DORAN’S RECYCLING LTD.619530 DR HOUFAR SEKHAVAT C.P. INC.639002 DR M.H. LANDRY C.P. INC.042210 DR. ANIL JOSHI PEDIATRIC DENTIST

PROFESSIONAL CORPORATION645496 Dr. Ansar Hassan Professional

Corporation607145 Dr. Marc Savoie C.P. Inc.632539 Dre Anick Pelletier c.p. Inc613002 Dre Mireille Charest-LeBlanc C.P. Inc.509552 DreamCatcher Publishing Inc.632606 DRL Auto Ltd.639053 DRYDEN OPTICS LIMITED638749 DUNHAM’S SEPTIC SOLUTION LTD.619821 Dynamic Drywall Inc.037560 E & Y PROPERTIES LTD.020184 EASTERN PUBLISHING LIMITED505121 EASTWIND SPECIALTY VENEERS

LTD.042217 ECO-HOUSE INC.645010 EcoLogic Lawn Care Inc.645310 ENCORE ENTERTAINMENT LTD.601755 ENERMOR HOLDINGS INC.507184 Entreprise Armand Roussel Inc.505014 ENTREPRISES D. PAILLARD INC.645004 Entreprises Damien Enterprises Inc.514831 ENTREPRISES E & E GODIN LTÉE645016 ENTREPRISES P.L.N. SAVOIE INC.632700 Épicerie Levasseur Inc.514678 EQUIPEMENTS H.L. EQUIPMENT

INC.509544 ESTEY ATLANTIC LTD.512265 ETC-Entrepreneurship Training

Consulting Inc.625853 EVENT TRADE LTD.645327 EVOLUTION APARTMENTS LTD.638689 Exploitations Vertes Inc.502591 FAIRFIELD-OGDEN HOLDINGS LTD.619778 Fairview Lanes (2005) Ltd.619779 Fairview Lounge (2005) Ltd.613278 FERME DU DIAMANT INC.502577 FERME ROMEO F. SAVOIE & FILS

LTEE638745 Five Points Contracting Ltd.644995 FOKISOFT TECHNOLOGIES INC.042373 FRAMEL INC.639146 FREDERICTON GUN SHOP INC.645152 FSC Franchise Systems Consultants Ltd.632719 G. CURTIS INVESTMENT SERVICES

INC.632256 G.B.M.C.N.C. Renovations Ltd.645180 GALLANT BUSINESS SOLUTIONS

LTD.030559 GARNETT URQUHART REALTY LTD.049978 GARY JOHNSON INC.625946 GATEWAY HOTELS & INNS INC.042151 GAUDET’S SERVICE STATION LTD.034017 GEMSCOPE LTD.607353 GENIEO PROTOTYPE INC.049070 GESTION G. P. INC639110 Gestion J.D.G. Holdings Inc.512164 Gilbert Welding Ltd.601640 GinoMax Holdings Inc.645198 Glencairn Educational Services Ltd.509611 GRANDPA’S WHISTLE LTD.

The Royal Gazette — May 18, 2011 601 Gazette royale — 18 mai 2011

051872 GRAY VALLEY FARMS LTD.632413 Great Canadian Pub Inc.645181 GREENE DAWN CLEANING SERVICE

INC.020263 GUIMOND BOATS LTD.645269 Gunn Holdings Ltd.010042 GVL HOLDINGS LTD.047704 H. C. R. INVESTMENTS LTD.007515 H. GREER & SON LTD.502605 HABITATIONS GL INC.047713 HACHEY IMPRESSION LTD.645195 Happy Hopyard Inc.632503 HART REALTY INC.007965 HERITAGE ACRES LTD.030481 HICKMAN PLUMBING LTD.514804 Holly’s Cafe Soha Inc.500288 HOLSTE TRANSPORT LTD.057898 HUNTER’S VENTURES LIMITED632709 IDEAL RECONSTRUCTION INC. -

RECONSTRUCTION IDEAL INC.632552 IMPORTS UNLIMITED INC.645258 Innovations Media Inc.509630 ISLANDVIEW LANDSCAPE &

DESIGN LTD.638748 J & L MARKETING LTD.607100 J & M Rentals Inc.008587 J. A. C. RADIO LTD.645011 J.C.A. TRUCKING LTÉE619583 J.T.M. Marketing Inc.645452 Jack the Doodle, Inc.645060 Jade Décor Inc.645271 James Dunn Trucking Inc.645294 Janos Toth Holdings Inc.619601 Jay-Jack Ltd.512320 JCT TRONÇONNEUSES INC.514690 JDE Capital Corporation632276 JEM VISION 3000 LTEE/LTD505110 JEREMIAH FARM PARK LTD.607199 Jolly Farmer Transport Inc.613069 Joseph J. Wilby Law Offices Professional

Corporation613173 JUST FOUR FISHERIES INC.607485 K-GEE LTD.054792 KAYUU Food Service Ltd.037458 KINGSTON AUTO REPAIR LTD.054371 KIPLING INVESTMENTS LTD.041929 KUSTOM TRUCK LTD.626097 L & M Developments Ltd.514665 L&P ENTERPRISES LTD.003488 L. H. CHAPPLE LTD.502667 L.P. CHIASSON SERVICE SANITAIRE

LIMITEE645018 LAKEVIEW CLEANING SERVICES

LTD.613198 LAONOVA INVESTMENTS LIMITED632202 Latouche Enterprises Ltd.009676 LAW’S ELECTRICAL CONTRACTING

LTD.607397 LE PETIT MAGASIN LTÉE030478 LEAMAN INDUSTRIES LTD.645095 Legends Hair Studio Ltd.509606 LENCO TECH LTD.042390 LEO’S “TAKE-OUT” INC.005805 LES ENTREPRISES ALDORIA

BOUDREAU LTEE030472 LES ENTREPRISES PAQUETVILLE

LIMITEE645379 LES MATÉRIAUX DOIRON LTÉE049633 LES MOULES G.L.C. LTEE - G.L.C.

MUSSELS LTD.033905 LES PECHERIES ROBERT

LEBOUTHILLIER LTEE639013 LEVI FINE HOME & GARDEN DECOR

INC.601912 Lobster Pot Direct Ltd.619621 Long Marsh Creek Holdings Inc.509691 LTC GROUP MARKETING LTD.035705 MACMULLIN’S FARM LTD.

505125 MACQUARRIE ENTERPRISES LTD.645077 MAISON DE COMMERCE

ACADIENNE INC./ACADIAN TRADING HOUSE INC.

632377 Maje International Ltd.645216 MALIBU LANDSCAPING LTD.051953 MANOIR BASQUE LTEE/MANOR

BASQUE LTD.645035 Maritime Coupon Services Inc.034023 MARITIME PROPELLERS

REBUILDING LTD.010604 MARITIME PSYCHOLOGICAL

SERVICES LTD. - SERVICES PSYCHOLOGIQUES DE MARITIMES LTEE.

632427 Mark Realty Ltd645307 MARS TRANS INC.645161 Martin Savoie Construction Ltée625874 MASTERCARE AUTO SERVICE INC.035661 MAX MEDIA LTD.632614 MAXON and ASSOCIATES Inc.626161 MaxSam Safety Inc.644996 McCluskey Brothers Inc.049660 MDK VENTURES INC.504975 MECHFO OPERATIONS INC.632638 MEGAMARK INC.645330 Meier-Air-Services Ltd.645270 Melnychuk Holdings Ltd.632553 Menu Book Inc.626302 MICHAEL R. VERNER CONSULTING

INC.619133 MILL STREAM CONSULTANTS LTD.042162 Millennium Marine Inc.030565 MILLIDGE PLACE LIMITED613267 MINDSET RESOURCES LTD.037496 MIRAMICHI MAINTENANCE LTD.644979 MIRAMICHI TREE SERVICE LTD.644998 Miss Mac Consulting Inc.639145 Moore Financial Services Inc.644983 MOORE PROPERTIES &

RENOVATIONS LTD.020141 NASHWAAK PROPERTIES LTD.033938 NEGUAC BAY PRODUCTS LTD./LES

PRODUITS BAIE DE NEGUAC LTEE619369 New Vision IT Inc.020260 NEWTOWN HOLDINGS LTD.607349 Ocean View Cemetery Inc.601850 Ogilvy Hardwoods Inc.012553 OLIVERS GARDENS LTD.626245 OSTARA ENTERPRISES LTD.638740 Ottoman Trucking Ltd.030535 P. FOX & PARTNER LTD.638661 P. J. Taylor Trucking Ltd.512319 P.I.&E. SERVICES INC.645468 Pacific Technology Solutions Inc.638667 Parago Communications Canada Inc.638657 PARKS CONTROL SERVICES INC.632246 PAUL’S FRESH MARKET FOODS LTD.625911 Planifor inc.050124 PLASTECH (1991) LTD./LTEE645354 Played Out Fun Centre Ltd.512130 PRELAM ENTERPRISES LTD.619364 Premier Building Maintenance Inc.047481 PRINTING PLUS LIMITED645148 Project Finance Corporation638575 ProStar Electrical Services Inc.632586 PROTOTAL INC.509603 PROVINCIAL SECURITY AND

INVESTIGATION SERVICES LTD.042202 R & D WOOD PRODUCTS LTD.057942 R & S AUTO SALVAGE INC./

RECYCLAGE D’AUTO R & S INC.645516 R&P GLOBAL VENTURES LTD.054204 R. FRASER CONSTRUCTION LTD.626240 RayMarc Enterprises Ltd.612798 RÉPUBLIQUE DRYWALL & PAINT

INC.645299 Résidence Belle Rivière Inc.

645280 RIGHT WAY CONSTRUCTION LTD.054773 RIVER VIEW LOUNGE LTD.607209 RIVERS EDGE VENTURES INC.645119 Riverside Park Investments Inc.613357 Rockwood Software (2004) Ltd.645073 S. Butterfield Consulting Corp.509621 S. W. UNDERHILL TRUCKING LTD.014606 SAINT JOHN DRYWALL LTD.632300 Saint John Heritage Builders INC.632610 SAINT JOHN WINMAR LTD.632572 Sandra Mark Incorporated054821 SARTECH EDUCATION CORP.632645 SAVE ’N’ CARE AUTO SERVICES

LTD.613396 SEPARATION TECHNOLOGIES

CANADA LTD.058015 SERVICE SANITAIRE NABLA LTEE613199 SERVICES FORESTIERS RCR INC042289 SHEPODY CONTRACTING LTD.639039 Shike’s Place Ltd.638969 Shipwreck Galley Restaurant Ltd.644976 SIMPLY MORTGAGES LTD.632688 Sixty-Six Investments Ltd.601553 SMALLTOWN SIX LTD.514551 SmitKin Inc.045251 SOMMERVILLE FLOORING LTD.645282 SPA EXPRESS INC.645070 SPACESHIP HOBBIES LTD.626129 Spineco Investments Ltd.607262 ST. ANNE INDUSTRIES LTD.639073 St. James Resources Inc.015568 STEEVES FUELS LTD.035616 STEWART SURVEYS LTD.015618 STILES BODY REPAIR LTD.045023 STREETS AUTO SERVICE LTD.045283 STRUCTURE 2000 INC.512094 SUNSET PLACE INC.626467 SUNSHINE TERRACE LTD.507120 SUSSEX CORNER BOWL LTD.613117 Sustainable Land Management Limited505050 SYNCROPACT CRUSHING SYSTEMS

INC.632240 T.M.F. EXTREME RACING INC.013805 TANTRAMAR AGENCIES LTD.645503 Taster’s Pick Inc.645380 THE AMIRAULT CAR SPA INC.500266 THE BUTLER CARPET CLEANING

SERVICES LTD.045195 THE BUXTON PROFESSIONAL

CORPORATION638916 THE GIRLS BRA SHOP INC.619641 The Mahmud Group Inc.512317 The Malone Homestead Company Inc.626134 THE MORTGAGE MAKERS INC.512253 THUNDER MOUNTAIN

ENTERTAINMENT INC.638843 Tim Allen Ltd.645092 TLC HAIR STUDIO LTD.626304 TOM McGINN TOURS LTD.619723 Trendy Services Inc.505001 TWIN ELECTRICAL & MECHANICAL

CO. LTD.042239 VALLIS TRUCKING LTD.045073 VASHY INC.645463 Vente DAVMAR Sales Inc.016737 VERRET’S FUNERAL HOME LTD.613321 VILLAGE SQUARE BAKE SHOP LTD.039778 W. E. COLWELL ENTERPRISES LTD.632538 WESTSIDE VARIETY & VIDEO LTD.638656 Wharfside Fish Market Ltd.645266 Wheelbase Holdings Ltd.514649 Whirlteq Inc.632637 White Wave Ltd.021346 Worrall’s Investments Ltd.632626 X Gen Technology Inc644978 Yummy Samosas Inc.632406 Yvette Levesque Courrier Inc.

_____________________________________________________

The Royal Gazette — May 18, 2011 602 Gazette royale — 18 mai 2011

645158 1229797 Alberta Inc.612157 6215955 Canada Inc.645390 9124-7643 Quebec Inc.073333 ABB Inc.632204 BEAUX ELECTRIC INC.626196 Blue Note Mining Inc.645349 COMPAGNIE DE GESTION GILLES

RICHARD INC.626204 DENVER SUBS CANADA

FRANCHISEE ASSOCIATION632592 Flying J Canada Transport Inc.625926 Geodex Minerals Ltd

077254 LES OEUFS RIVERVIEW EGGS INC.613029 LES RESTAURANTS IMVESCOR

INC./IMVESCOR RESTAURANTS INC.

632520 Lindsay & Associates Fire Services Inc.075416 NOVUS INTERNATIONAL (CANADA)

INC.626407 O.K. Tire Stores Inc.645361 Olympian Financial Inc.638477 PostQuam Canada Corp.632292 PROTOS DEVELOPMENTS INC.631428 Robertson Hall Insurance Inc.

626220 SERDETRA SERVICES & TRADING INC.

077227 SHELLCO CREDIT SYSTEMS LTD612993 Spheric Technologies Inc.076772 UNDERLINES INC.645134 VENTURE CHEM INC./ENTREPRISE

CHEM INC.626490 Westwood Developments Limited070937 WILLIAM COMEAU PLOMBERIE ET

CHAUFFAGE LTEE

626440 Apprentissage pour Adultes Péninsule Inc.

025473 Association of Visual Language Interpreters of New Brunswick (AVLI-NB) Inc.

023673 ASSOCIATION PROTECTRICE DE L’ENVIRONNEMENT INC.

010281 BARREAU DU MADAWASKA INC./MADAWASKA LAW SOCIETY INC.

024423 BELLEDUNE REGIONAL ENVIRONMENT ASSOCIATION INC.

001743 BELLEISLE CREEK CEMETERY LIMITED

645149 BRIDGEHOUSE MINISTRIES INTERNATIONAL INC.

626351 CAFÉTÉRIA NUTRI-SOL INC.612772 Caravanes mer et terre: Acadie 2004 inc.003351 CENTRE RECREATIF DE ST. ARTHUR

INC.025471 CLUB V.T.T. DE L’ILE LAMEQUE INC.004071 COMITE DE LOISIRS DU FAIR-ISLE

INCORPORE024610 CUMBERLAND POINT UNITED

BAPTIST COMMUNITY CEMETERY LTD.

023769 EPSILON Y’S MEN’S CLUB INC.023197 FREDERICTON SNOWMOBILE CLUB

INC.

632607 FRIENDS OF ROCKWOOD PARK INC.645084 K V Fields Committee Inc.025286 K.V. Committee for Disabled Persons Inc.645157 L’Association des familles Arsenault

Family Association Inc.645236 L’ASSOCIATION DES FAMILLES

VIENNEAU INC.021903 L’ATELIER R.A.D.O. INC.021624 LE CLUB D’AGE D’OR DE

ST-PHILIPPE INCORPOREE024617 LES AMIS DU VILLAGE HISTORIQUE

ACADIEN INC.025463 MARCHÉ DES FERMIERS DE

BOUCTOUCHE INC. - BOUCTOUCHE FARMERS’ MARKET INC.

011119 MISS NEW BRUNSWICK BEAUTY PAGEANT, INC.

022933 MISSION TO MILLIONS CHRISTIAN MINISTRIES INC.

011259 MONCTON GUN CLUB, LIMITED626033 MUSQUASH ATV CLUB INC.024759 NORTH WESTERN N.B. BLUEGRASS

& OLDTIME MUSIC ASSOCIATION INC.

607076 OFFICE DU TOURISME EDMUNDSTON MADAWASKA INC.

025136 PONT BAS-CARAQUET/SHIPPAGAN INC.

013957 REXTON LIONS CLUB INC.632273 ROTARY CLUB OF PERTH-

ANDOVER, INC.021608 SAINT JOHN REGIONAL HOSPITAL014672 SAINT JOHN Y’S MEN’S PROPERTY

COMPANY LIMITED021629 SALISBURY LIONS SENIOR

CITIZENS COMPLEX INC.024782 SCOODIC FISH & GAME

ASSOCIATION INC.021615 SERVICE D’AIDE A LA FAMILLE

D’EDMUNDSTON/GRAND-SAULT INC.

644800 ST. ANDREWS SENIOR CITIZENS CLUB INC.

014686 ST. MATTHEW EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH

020149 ST. VINCENT’S BOYS- ST. MALACHY’S MEMORIAL HIGH SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION INC.

645343 THE CHARLO HATCHERY FOUNDATION INC.

007409 THE GRAND MANAN HOSPITAL, LIMITED

021654 THE MILLTOWN BAPTIST CHURCH OF THE SAINT STEPHEN AREA

013413 THE PROGRESSIVE CLUB OF OLD RIDGE, LIMITED

Notice of decisionto cancel the registration of extra-provincial corporations

Take notice that the Director under the Business Corporations Act hasmade a decision to cancel the registration of the following extra-provincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, asthe said corporations have been in default in sending to the Directorfees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that60 days after the publication of this Notice in The Royal Gazette, theDirector may cancel the registration.

Avis d’une décisiond’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales

Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporationscommerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corpo-rations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de laLoi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir auDirecteur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez aviséque 60 jours après la date de la publication du présent avis dans laGazette royale, le Directeur pourra annuler l’enregistrement desditescorporations extraprovinciales.

Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provincialesSoyez avisé que le Directeur, en application de la Loi sur les compa-gnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertude l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait dé-faut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents re-quis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publicationdu présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudrelesdites compagnies.

Loi sur les compagnies

Notice of decision to dissolve provincial companiesTake notice that the Director under the Companies Act has made a de-cision to dissolve the following companies pursuant to paragraph35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in send-ing to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act.Please note that 60 days after the date of publication of this Notice inThe Royal Gazette, the Director may dissolve the companies.

Companies Act

The Royal Gazette — May 18, 2011 603 Gazette royale — 18 mai 2011

096620 THE SHEDIAC RIVER FISHING CLUB COMPANY,(LIMITED)

021895 THE SMALL CRAFT AQUATIC CENTER OF FREDERICTON INC.

024208 THE ST. JOHN RIVER SOCIETY INC./LA SOCIETE DU FLEUVE SAINT-JEAN INC.

022928 THE ST. MARTINS BEAUTIFICATION SOCIETY INC.

021642 THISTLE-ST. ANDREWS CURLING CLUB

025470 TURNING POINTS YOUTH PARENT & EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTRE INC.

025617 VISIT CANADA VISITEZ INC.025619 West Isle Whale Watching Association

Inc.021138 WICKLOW COMMUNITY

CEMETERY INC.

346604 Broad Meadow Trophies624062 Chat Sur Toi336085 COUNTRY HAVEN LODGE349116 DND enterprises624842 HILLSBOROUGH BAKERY &

COFFEE SHOP624855 Interior Motives

624743 J.N.C. Cleaning624996 MARLOW WOODWORKING

ENTERPRISE624949 NetProtect Technologies349065 NEW HORTON LAKE INN349155 Pet Tails Animal Care349227 PICTURE HEAVEN STUDIO

624769 Roland & Debbie Jaillet enterprise624883 SCRAP-IT-UP349109 SUNPOKE LUMBER351471 THE FAMILY CAFE625130 W. & L. MACDONALD USED CARS

349090 A D H Services624764 A Nu U Day Spa624945 A Touch of Eden Landscaping346671 A-1 Duct Cleaning625113 Afterglow Aesthetics625066 AIR ALLIANCE625067 AIR BC625070 AIR CANADA JAZZ625071 AIR CANADA REGIONAL625072 AIR CANADA RÉGIONAL625063 AIR NOVA625068 AIR ONTARIO624989 AL’S RENO351580 Alpha’s Appliance Solutions625048 André-Luc Bisson Maître Plongeur/

Master Diver enr./reg’d333541 AQUAPHER ANALYSIS349205 ARGUS PETROLEUM349235 Assurance de l’Anse625025 Atlantic Contractor Referral Service346682 ATLANTIC GEO-TECHNOLOGY348964 ATLANTIC IMAGES.COM

301949 ATLANTIC TRADE EVALUATION SERVICES

314842 AUDREY’S NURSERY624785 AVE Audio Video Entertainment624888 Aventure Mt Carleton Adventure625210 B & L Small Engine Service and Repair346743 Barrett Distributors346712 Bay Fresh Seafoods346666 BAYER DIAGNOSTICS349136 Beach Hill Landscaping351494 BELL HELICOPTER TEXTRON

CANADA625114 BKI Risk Management625055 Blinds Solutions323436 BOUTIQUE ZIG ZAG335984 BREATHEASY SERVICES624909 Bridges & Son Scrap Metal346765 Bubbles To Beauty625064 CANADIAN REGIONAL AIRLINES625027 CANADIAN WATER SERVICES624862 Cardigan Construction346711 CARDINAL PUBLISHING

624896 Cartoon Keepsakes346771 CASPARO TRUCKING346723 Chickadee Lodge624905 Chris’s Electrical Mechanical624738 CIT Commercial Finance624736 CIT Leveraged Finance624735 CIT Systems Leasing624910 CJ Vending Machines624838 Cloud Nine Aesthetics625111 CLUB CHAMELEON625251 Club PhénoMènE336103 COBURN’S POULTRY FARM624884 Common Cents Financial Services624950 CONTOURS EXPRESS -

FREDERICTON624475 Cormier Machining624893 Counseling Solutions... Hope & Healing625236 Country Burst Delight’s625011 Country View Apartments624586 Couture Plourde LaPlante624869 Couturier Navigation346595 Craig Equipment

SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi surl’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations com-merciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a l’intention, envertu de ladite loi, d’annuler l’enregistrement des certificats de sociétésen nom collectif indiquées à l’annexe « A » ci-jointe et des certificatsd’appellations commerciales des commerces indiqués à l’annexe « B »ci-jointe, en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé defaire enregistrer des certificats de renouvellement conformément àl’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selonle cas.SACHEZ AUSSI qu’en tout temps après la date d’expiration de trente(30) jours à partir de la date de publication du présent avis, le registrairepeut annuler l’enregistrement desdits certificats de sociétés en nomcollectif et certificats d’appellations commerciales.

Loi sur l’enregistrement dessociétés en nom collectif et

des appellations commerciales

TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Part-nerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5,the Registrar under the said Act intends to cancel the registration of thecertificates of partnership of the firms set forth in Schedule “A” an-nexed hereto and the certificates of business names of the businessesset forth in Schedule “B” annexed hereto by reason of the fact the saidfirms and businesses have failed to register certificates of renewal inaccordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7),as the case may be applicable, of the said Act.

FURTHER TAKE NOTICE that at any time after the expiration date ofthirty (30) days from the date of publication of this Notice, the Regis-trar may cancel the registration of the said certificates of partnershipsand certificates of business names.

Partnerships and BusinessNames Registration Act

Schedule “A” / Annexe « A »Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif

____________________________________________________

Schedule “B” / Annexe « B »Certificates of Business names / Certificats d’appellations commerciales

The Royal Gazette — May 18, 2011 604 Gazette royale — 18 mai 2011

346596 Craig’s Auto Clinic625092 CREEKSIDE CRAFTS624925 D & L VENTILATION349083 D&M AUCTION CENTRE625219 D. DOIRON CONSTRUCTION625259 Daigle Photo Restoration & Retouching351582 DANIEL DUPUIS ENTREPRISE ENRG.317203 DANNY’S INN & CONFERENCE

CENTRE349157 Dave’s Place624832 Dekitbo Management Group624763 Dietitians On The Go625256 Distribution D & C624746 Ditech Logistics624973 Doucet Travel625257 DPM Consulting346685 DREW KELLEY CONSTRUCTION625074 Dusty McSorley Light Trucking624876 E & I Doucet Lawn Care625117 E J’s Cleaning320343 E. A. BOUCHER’S PAVING AND

CONSTRUCTION349255 EAST COAST SPORTS VENTURE625035 easyfinancial Services349221 ECLIPSE CUSTOM BLINDS625231 Exit Realty Day’s624979 Extreme Steam624744 FABULOUS FINDS624991 Film Pix625182 FINDER 5000625239 Firefly Design624998 Flair & Function317233 FOREST HILL GROCERY & VARIETY348877 FOUR SEASONS TROPHY &

ENGRAVING CENTRE QUATRE SAISONS CENTRE DU TROPHÉ & GRAVURE

624987 Frank’s Place349213 FREDERICTON KIA625169 FRYDAZE CANTEEN624964 G & A Auto Body625227 Gardiner Realty Royal LePage625225 Gerrior Transport320188 GESTEX624898 Givens Games625118 Global Cleaning & Painting344136 GOGUEN LUMBER625131 Golf Technique624797 Gonzonistics Media Studio349113 Grand Falls Custom Upholstery624935 Grant MacKenzie Painting625204 grant’s donair624411 Graphics 1st625002 HANNAFORD PROPERTIES625119 Harmony Self Care Project624809 Healthy Spaces606117 Helpful Hands Bargain Centre349020 HERITAGE DISCOVERY TOURS625105 Heritage Painting349175 Hertz Equipment Rental624793 Hidden Place Studio a la Cachette624479 Hillsborough Home Hardware624450 HOUSEHOLD624962 HYDRA BEVERAGE CO.625101 Insights Learning and Development

(Atlantic)624865 Intelligent Touch Massage Therapy624786 itsoldonline.ca625147 J.A.M. Transport624941 J.G.CARPENTRY349149 JAC’S PAWNSHOP624765 Jack in the Box Art’s & Crafts625069 JAZZ624958 Jean-Paul Rocher IT Consultant349096 JEANNETTE HAIR DESIGN624748 Jeege’s Clothing Boutique

625232 JILLY’S DANCE BAR348945 JIM DAY SALES AND SERVICE349233 JULIAN H. WALKER & ASSOCIATES351593 justforthefunofit625123 K & A Locks625054 KIAP Films & Entertainment624848 Kingswood Academy Day Care349209 KM Sign Centre625216 La Maison du Vieux Moulin624373 LAWRENCE M BISHOP CONSULTING

SERVICES349198 LAZY GETAWAYS625193 Lean Management Tools & Consulting349129 LeBlanc’s Tae Kwon Do351406 Legere & Associates624392 Les Gouttières Du Nord Ouest348954 LES INVESTISSEMENTS HA

LEQUANG INVESTMENTS ENR.311278 LEWIS PHARMACY625065 LIGNES AÉRIENNES CANADIEN

RÉGIONAL349197 LITTLE BARN PRODUCTIONS624978 LYNDA RAE BURKE Fine Art624861 M K Landscaping624823 M.F. Recycling & Demolition346670 MacDonald’s Service Center341427 MACGREGOR SLEEP PRODUCTS346668 MACLEAN’S POWERSPORTS348869 Magasin S.M.R.625198 MARCEL MASSE PLANCHERS DE

BOIS FRANC & ESCALIERS MARCEL MASSE HARDWOOD FLOORS & STAIRS

624907 Marine Endeavors624814 Maritime Fish349194 MARITIME MONEY LENDERS624997 Marla’s Country Hair Care315017 MAUGER EQUIPMENT RENTALS624805 McCready Palmer & Associates624850 Melinda Daamen, CGA624829 Michael Young Painting336090 MICRO MARCHE DEPANNEUR346605 MILLENNIUM INDUSTRIES625001 Miramichi Mazda624917 Musique Chaleur Music625050 MY SISTER’S CLOSET625127 Nails Fantastic351068 NEW BRUNSWICK FIDDLERS

ASSOCIATION/FIDDLE VIOLON NB625079 New Haven Landscaping and renovations346800 NHS Together in 2000349256 OAKES ENTERPRISES625144 Off The Wall Graphics624969 Organizational Improvement Services624433 Oromocto Day Care Center624432 Oromocto West Child Care Center625082 Ostrea Product624856 OULTON COLLEGE625191 Our Power Research & Development624983 Out of The Woodwork625044 Pathway Glass625248 Paul Richard & Associates625258 PCs TaylorMade351306 Peninsula Concrete625112 Pete’s Auto Shop624940 Peterbilt New Brunswick319593 PINE GROVE FARMS351469 Prolite Windows & Doors625163 PROTEK-RAIL625139 Quality Inn / Edmundston625207 QUANTUM BOOKKEEPING349026 R.S. Black Welding and Fabricating624745 REMBOURREUR ARMEL NOEL624822 Renforth Hair Studio624895 Renous River Antiques & Collectibles631584 Restaurant Beauport Enrg.

624447 Restigouche Home Care Services625057 RINO TAKE-OUT624721 Rustic Charm Cafe624767 Salon Fascination Beauty Salon625058 Savoir-Faire IS (SFIS)624770 Scichilone’s Homemade Italian Foods346646 Séduction Mode Enr.349189 SERVICES DE BUREAU DUPUIS/

DUPUIS OFFICE SERVICES625009 Sewell’s Concrete625010 Sewell’s Paving624794 Shediac Esthetics Salon625094 Shell Global Solutions Canada346577 Shepody Sales624806 Simpson Auto Body & Collision Center624859 SJ Enterprises333441 SJO FARM ENTERPRISES624358 Smiley Face Enterprises346665 Smitty’s Auto & Recreation349037 SNO-MO MAPS FOR

SNOWMOBILERS346744 Soleman Enterprises351470 SOLU-FLEX COMPUTING625253 Sonador Consulting624854 SOUTHEASTERN COAST TRUCKING625028 SPECIALTIES D’AQUEDUC DU

QUEBEC625185 STÉPHANE (HAIR SALON)624807 Storage World625223 Studio Concept Images engr625122 Sun & Cruise Travel Service625107 Swan Face Entertainment338789 T. M. S. DETAILING SERVICES624813 Tantramarsh Driving School625199 TAPIS & DRAPERIES HORIZON,

HORIZON CARPETS AND DRAPES349172 TAYBERRY FARMS625238 Thalie Soaps351446 The Couple & Family Growth Centre Le

Centre de Croissance Familiale et de Couple

624742 The Gourmet Goddess624783 The Job Log625030 The OddBall Knittery625243 The Sharp Pencil346720 The Somerset Pub625188 THE TRACY STORE624994 The Urban Market625181 THERIAULT SEASONAL SERVICES624796 Tibbits Consulting618316 Tom Hughes Roofing & Contracting624782 Top of the Town Restaurant346582 Traiteur à la Carte Catering625202 Treejacks346721 Trims By Kim Beauty Salon625138 TRIUMPH TRUCKING624968 TROUPE AZUR625106 Ultimate Spirit Athletics Cheer Club624792 VALLEY FRIES624788 VAN OORD NURSERY624715 VEILS TO VOWS WEDDING

PLANNING AND CONSULTING625061 VICWEST346755 VIVA INTERNATIONAL GROUP625205 W P Business Consulting349181 W. DYKEMAN CONSTRUCTION332148 WACKY WHEATLEY’S TV & STEREO624972 Walk In Bathtubs625214 Watt Broadcasting349203 WAYNE HOOPER CARPENTRY338679 WEDGEWOOD HALL625060 WESTEEL625212 WILLISTON SEPTIC & PORTABLE

TOILETS349267 Winterfest NB625081 Zap Magic

The Royal Gazette — May 18, 2011 605 Gazette royale — 18 mai 2011

Aches N Pains Massage Therapy & Wellness Inc. Riverview 656533 2011 03 23

Atlantic-Navis Vessel Services Ltd. Pennfield 657031 2011 04 28

Family Ties Play Care Inc. Saint John 657063 2011 04 18

FS Framing Ltd. Saint-Philippe 657077 2011 04 18

Inspired Events Productions Inc. Riverview 657087 2011 04 19

NEWMANS ROOFING & SIDING INC. Saint John 657125 2011 04 20

657126 N.B. Ltd. Boundary Creek 657126 2011 04 20

657128 NB Corp. Fredericton 657128 2011 04 20

657130 NB Inc. Beresford 657130 2011 04 20

AL MARSA CONSULTING SERVICES INC. Moncton 657131 2011 04 20

Corporation Professionnelle Dr. Joseph Alfred Nembo N. Moncton 657133 2011 04 21

Tyco Logging Ltd Johnville 657138 2011 04 21

BSMD Trucking Ltd. Chipman 657139 2011 04 21

Dynamic Discounters Inc. Fredericton 657140 2011 04 21

PRODUCTION VAPO INC. Notre-Dame-des-Érables 657141 2011 04 21

Progressive Business Solutions Inc. Nasonworth 657142 2011 04 21

A. HARRIGAN INVESTMENTS CORP. Quispamsis 657143 2011 04 21

On Track Business Consultants Inc. Moncton 657150 2011 04 21

657151 NB Ltd. Saint John 657151 2011 04 21

657152 NB Inc. Fredericton 657152 2011 04 21

657153 N.B. Inc. Moncton 657153 2011 04 21

Ground Breaking Backhoe Services Ltd. Saint John 657154 2011 04 21

Gary Daigle Construction Ltd. Lakeville 657159 2011 04 21

You Better Belize It Hot Sauce Inc. Springfield 657162 2011 04 23

Iceberg Acqua Products Corp. Saint John 657163 2011 04 25

Robinson’s Crown Exteriors Ltd. Saint John 657164 2011 04 25

657165 NB INCORPORATED Miramichi 657165 2011 04 25

657179 N.B. Inc. Rogersville 657179 2011 04 26

Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commercia-les, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

The Royal Gazette — May 18, 2011 606 Gazette royale — 18 mai 2011

Carber Construction Management Inc. Quispamsis 657180 2011 04 26

Y.C.C.N. (YANG & CAO CENTRAL NATION) LTD. Saint John 657181 2011 04 26

657183 NB Inc. Fredericton 657183 2011 04 26

Greenfield Mining Services Inc. Miramichi 657189 2011 04 26

Stewart’s Cable Contracting Inc. Moncton 657190 2011 04 26

SSD Holdings Inc. Fredericton 657191 2011 04 26

KER Logging Ltd. Moose Mountain 657192 2011 04 26

AFFUTAGE CHALEUR SHARPENING INC. Beresford 657196 2011 04 27

ProCheck Home Inspections Inc. Shediac 657198 2011 04 27

657199 N.B. Inc. Shediac 657199 2011 04 27

Colby Comeau Logging Ltd. Juniper 657200 2011 04 27

Aberdeen Asset Management Canada Limited Saint John 657201 2011 04 27

657204 N.B. LTD. Richibucto 657204 2011 04 27

Susette Instrum PC Inc. Fredericton 657214 2011 04 27

Shady Lane Investments Inc. Mundleville 657215 2011 04 27

J & M Lyons Trucking Ltd. Porter Cove 657217 2011 04 27

French House Investments Limited Saint John 657219 2011 04 28

The Log Cabin Restaurant Inc. Hopewell Cape 657220 2011 04 28

657221 N.B. Inc. Hopewell Cape 657221 2011 04 28

Dans les draps de Morphée Inc. Campbellton 657224 2011 04 28

The Caves Restaurant Ltd. St. Martins 657230 2011 04 28

Brunan Holdings Ltd. St. Martins 657235 2011 04 28

PALETTE R.M. INC. Sainte-Marie-Saint-Raphaël 657238 2011 04 28

GESTION MARC DEGRACE LTEE Shippagan 657239 2011 04 28

657240 N.B. LTD. Holmesville 657240 2011 04 28

W. R. Rickard & Associates Inc. Island View 657241 2011 04 28

GENCOM SECURITY SYSTEMS & TECHNOLOGIES INC. Campbellton 657242 2011 04 28

Danny’s Improvements Inc. Red Bank 657253 2011 04 29

DR. XIANG C.P. INC. Moncton 657254 2011 04 29

Art’s Labor Services Inc. St. André 657255 2011 04 29

HEAD POND FARMS (2011) LTD. Fredericton 657266 2011 04 29

_____________________________________________________

The Royal Gazette — May 18, 2011 607 Gazette royale — 18 mai 2011

ASSURANCE BELLIVEAU INSURANCE LTÉE/LTD. 032690 2011 04 25

Gestion Ray Michaud Ltd. 043290 2011 04 28

056531 N.B. LTD. 056531 2011 04 26

TETAGOUCHE HOLDINGS INC. 508174 2011 04 28

HOPEWELL ROCKS MOTEL & COUNTRY INN, INC. 508845 2011 04 28

MRPI GROUP INC. 516306 2011 04 28

605341 NB LTEE 605341 2011 04 28

605342 NB LTEE 605342 2011 04 28

606018 N.B. Ltée 606018 2011 04 28

DR. HAJI ADAM VAYANI PROFESSIONAL CORPORATION 627455 2011 04 27

R & J Cunningham Investments Inc. 637908 2011 04 29

Four Seasons Recycling Inc. 649042 2011 04 28

651719 N.B. Inc. 651719 2011 04 25

ASSURANCE B. BELLIVEAU INSURANCE INC. 655772 2011 04 25

656409 New Brunswick Ltd. 656409 2011 04 21

_____________________________________________________

034687 N.B. LTD. TOM’S CONCRETE FORMS LTD. 034687 2011 04 27

ARCELORMITTAL BATHURST INC. Atcan Iron & Metal Inc. 624555 2011 04 28

enXco Service Canada Inc. enXco Service (Canada) Corporation 640885 2011 04 21

Global System Dynamics Holdings Inc. Fantastic North America Inc. 648636 2011 04 26

CAI Nunatsiavut Marine Inc. CAI Marine Inc. 654652 2011 04 29

Rocky’s Sports Bar Inc. 657028 N.B. Ltd. 657227 2011 04 29

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

The Royal Gazette — May 18, 2011 608 Gazette royale — 18 mai 2011

657028 N.B. Ltd. ROCKY’S SPORTS BAR INC. Saint John 657227 2011 04 29657028 N.B. Ltd.

_____________________________________________________

J. & L. FANJOY’S GENERAL STORE LTD. Jemseg 052755 2011 04 27

507076 N.-B. LTEE Bas-Caraquet 507076 2011 04 20

Herbal Magic of Quispamsis Inc. Darlings Island 629366 2011 04 21

Qualipro Distribution Inc. Maple View 637606 2011 04 26

JGR Consultants Inc. Maple View 644848 2011 04 26

Gestion de Propriétés Vertical Property Management Inc. Dieppe 651554 2011 04 20

_____________________________________________________

Thermaray Inc. Fredericton A.C. Poirier & Associates Inc. 059675 2011 08 20

_____________________________________________________

EVERETT LORD HOLDINGS LTD. 049000 2011 04 21

Adam Ramsay Well Drilling Inc. 638259 2011 04 26

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :

ReferenceNumber Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, notice of the discharge of a receiver or a receiver-manager of the following corporations has been received:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un avis de libération d’un séquestre ou séquestre-gérant pour lessociétés suivantes a été reçu :

Receiver or ReferenceReceiver-Manager Number Date

Registered Office Séquestre ou Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré séquestre-gérant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

The Royal Gazette — May 18, 2011 609 Gazette royale — 18 mai 2011

DOMINO’S PIZZA OF CANADA LTD. Ontario SMSS Corporate Services (NB) Inc. 656868 2011 04 08Saint John

MCW Consultants Ltd. Canada Mike Gillis 656897 2011 04 11Moncton

Maritech Commissioning Works Ltd. Canada Mike Gillis 656899 2011 04 11Moncton

U Neek Brands Ltd. Alberta SMSS Corporate Services (NB) Inc. 656931 2011 04 12Saint John

6586856 Canada Inc. Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc. 656932 2011 04 12Saint John

ALEX MACINTYRE & Ontario Michael A. Gillis 656939 2011 04 12ASSOCIATES LIMITED Saint John

Eastern Shore Safety Services Inc. Canada Peter Adams 656983 2011 04 26Fredericton

6422217 Canada Inc. Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc. 656988 2011 04 14Saint John

Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657005 2011 04 14Inc. Laurentian Bank Securities Inc. Saint John

Ascendant Securities Inc. Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657053 2011 04 18Saint John

THE READER’S DIGEST Alberta SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657054 2011 04 18ASSOCIATION (CANADA) ULC Saint John

Surplus R.D. inc. Québec / Quebec Sophie Caissie Cormier 657076 2011 04 18Moncton

AEGIS London Services (Canada) Inc. Canada Edward W. Keys 657100 2011 04 19Saint John

7729502 Canada Inc. Canada Alan Hicks 657109 2011 04 28McKees Mills

GRAHAM DESIGN BUILD Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657111 2011 04 20SERVICES LTD. Saint John

Gandhi Planning Inc. Canada Indrajit Gandhi 657168 2011 04 26Saint John

JARDEG CONSTRUCTION Alberta SMSS Corporate Services (NB) Inc. 657170 2011 04 26SERVICES LTD. Saint John

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

The Royal Gazette — May 18, 2011 610 Gazette royale — 18 mai 2011

1346022 Alberta ULC 1507396 ONTARIO LIMITED 078006 2011 02 11

Troy Life & Fire Safety Ltd. TROY SPRINKLER LIMITED/ 631094 2011 04 12Protection incendie Troy Ltée TROY GICLEURS LIMITÉE

GP CAR AND HOME INC. / GREY POWER INSURANCE BROKERS INC. 652786 2011 04 15GP AUTO ET HABITATION INC.

_____________________________________________________

NFL Holdings Ltd. BAY FERRIES LIMITED SMSS Corporate Services 656870 2011 04 08(NB) Inc.Saint John

YM Inc. (Sales) YM Inc. (Sales) SMSS Corporate Services 657020 2011 04 15(NB) Inc.Saint John

Armstrong World Industries ARMSTRONG WORLD John Laidlaw 657032 2011 04 15Canada Ltd. Les Industries INDUSTRIES CANADA LTD. Saint JohnMondiales Armstrong Canada Ltee

WESTOWER WESTOWER SMSS Corporate Services 657052 2011 04 18COMMUNICATIONS LTD. COMMUNICATIONS LTD. (NB) Inc.

Saint John

3M Canada Company- 3M Canada Company- SMSS Corporate Services 657057 2011 04 18Compagnie 3M Canada Compagnie 3M Canada (NB) Inc.

Saint John

Armstrong World Industries Armstrong World Industries John Laidlaw 657184 2011 04 15Canada Ltd. Les Industries Canada Ltd. Saint JohnMondiales Armstrong Les Industries Mondiales Canada Ltee Armstrong Canada Ltee

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :

ReferenceNumber Date

Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :

ReferenceAgent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

The Royal Gazette — May 18, 2011 611 Gazette royale — 18 mai 2011

Friends of Kingston Peninsula Inc. Summerville 657099 2011 04 19

_____________________________________________________

LIFTING JESUS HIGHER MIRAMICHI EVANGELICAL 023888 2011 04 20MINISTRIES INC. MINISTERIAL ASSOCIATION INC.

Traduction Lysandre Monique Sénéchal Fredericton 655719 2011 04 26Translation

NU Growers Network Geoffrey Locke Lincoln 656416 2011 03 16

YORKVILLE UNIVERSITY Yorkville Education Company Fredericton 656660 2011 04 19ULC

Cedar Brook Landing River Lodge Ernie Doiron Browns Yard 656670 2011 04 20

Greenfield Stable Amanda White Greenfield 656777 2011 04 04

Taxi - St-Basile et Taxi Camille Jacques Morin Edmundston 656819 2011 04 29

J. B. Scott Electric and Jeffrey Scott Grand Barachois 656859 2011 04 07Automation Services

Bay Ferries NFL Holdings Ltd. Saint John 656871 2011 04 08

MCW MARICOR CONSULTANTS MCW Consultants Ltd. Moncton 656898 2011 04 11

MARITECH COMMISSIONING Maritech Commissioning Works Moncton 656900 2011 04 11WORKS

Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,

letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres

patentes ont été émises à :

ReferenceNumber Date

Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent, which include a change in name,have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires, contenant une nouvelle raison sociale,ont été émises à :

DateNew Name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Nouvelle raison sociale Numéro de référence année mois jour

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

The Royal Gazette — May 18, 2011 612 Gazette royale — 18 mai 2011

Reps 24 Training & Fitness Center WILLIBS A TO Z Woodstock 656908 2011 04 11SERVICES INC.

Les Appartements M.D. Michel Doiron Saint-Georges 656910 2011 04 20

ATLANTIC FASHION Emile Cormier Riverview 656911 2011 04 20EXHIBITORS (Riverview) Donald Botten

Noonan Anthes

PELLETIER MECHANIC & Marco Pelletier Anfield 656946 2011 04 20WELDING

Rouge Premiere Lounge & 641791 NB Inc. Moncton 656951 2011 04 28Night Club

Barrel Well Restaurant & Bakery Tanya Brown Welshpool 656999 2011 04 14

Miss Patricia Fashions Patricia Galbraith Fredericton 657001 2011 04 14

B. B. J. J. Construction Bobby Thériault Notre-Dame-des-Érables 657002 2011 04 14

C. Olsen’s Property Maintenance Chris Olsen Moncton 657004 2011 04 14and Handyman Services

Strata G Advisors Peter Hess Sackville 657012 2011 04 14

Rumors Night Club & Lounge Club Marz Inc. Campbellton 657034 2011 04 18

P.M.T. Contracting Peter Wade Kingston 657039 2011 04 15

Lazer-Tech Line Painting Wiley Proctor Gaudet St. George 657040 2011 04 15

Reader’s Digest THE READER’S DIGEST Saint John 657055 2011 04 18ASSOCIATION (CANADA) ULC

Reader’s Digest Canada THE READER’S DIGEST Saint John 657056 2011 04 18ASSOCIATON (CANADA) ULC

HAMPTON COMPUTER SHOP 655797 NB Ltd. Hampton 657075 2011 04 18

Summer Scoops T.J. MAILLET Moncton 657093 2011 04 19RESIDENCES LTD.

Shawn Chiasson Construction Shawn Chiasson Hardwick 657094 2011 04 19& Renovations

Stoney Brook Lodge 656832 N.B. Ltd. Fairfield 657096 2011 04 19

AEGIS LONDON AEGIS London Services Saint John 657101 2011 04 19(Canada) Inc.

GRAHAM DESIGN BUILD GRAHAM DESIGN BUILD Saint John 657113 2011 04 20SERVICES, A JV SERVICES LTD.

TLS Fleet Management TRANSPORTACTION LEASE Saint John 657114 2011 04 20SYSTEMS INC.

Valley Dental Specialists 624205 N.B. Inc. Quispamsis 657118 2011 04 20

WORK UNLIMITED Brenda Tremblay Colpitts Settlement 657119 2011 04 20

La Résidence Ciel France Blanchard Maisonnette 657124 2011 04 20

La garderie les Ti-Papoutes Michel LeBlanc Dieppe 657127 2011 04 20

S Hall Tire Muffler & Auto Scott Hall Sackville 657129 2011 04 20Repair Centre

LEGER DEMAIN MEDIATION Victor Leger Fredericton 657132 2011 04 20

The Royal Gazette — May 18, 2011 613 Gazette royale — 18 mai 2011

BarnabyRiver Manufacturing Chantale Agnus Vautour Rogersville Ouest / West 657137 2011 04 21

POP STUDIO Lindsay Vautour Rothesay 657144 2011 04 21

KJB Trucking Joey Bergeron Kedgwick 657145 2011 04 21

CORNERVIEW RENOVATIONS Corey Biggar Bloomfield Ridge 657147 2011 04 21

Farm Life Studio NB Normand Bradford Albert Mines 657148 2011 04 21

R & J Transfer Reginald Stockford Mount Pleasant 657149 2011 04 21

Forever Taste the Health Lisa Phillips Moncton 657161 2011 04 22

Ripples Auto Clinic Francis Viel Ripples 657193 2011 04 27

Inspiring Fitness and Darlene Kinney Burton 657194 2011 04 27Lifestyle Management

Leticia de Gante, Landscaping Mario Ismael Leon Canul Fredericton 657195 2011 04 27

Chubb Edwards UTC Fire & Security Canada Fredericton 657197 2011 04 26

S & M Processing Shawn Lovelace Astle 657202 2011 04 27

DONALD WRIGHT CONSULTING Donald Wright Woodstock 657203 2011 04 27

Biddington International Dale Biddington Moncton 657205 2011 04 27Distribution

James Sweeney RAM James Sweeney Durham Bridge 657208 2011 04 27Construction

Jerome Worth Construction Jerome Worth Hillsborough 657218 2011 04 27

Adrenaline Therapy Sion Goodine Woodstock 657229 2011 04 28

AL’S DOGS Alexander Stewart Cook St. George 657237 2011 04 28

KRAWLER KONCEPTZ Michelle Boutilier Quispamsis 657243 2011 04 28

Webtop Computer Services Micheal Mann Carlingford 657244 2011 04 29

M&H Inspections J. Ryan Donald Lower Greenwich 657250 2011 04 29

Acacia Fish Market Carson Johnson Saint Andrews 657260 2011 04 29

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMPartnerships and Business Names Registration Act / Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

In relation to the certificate of business name registered on April 20, 2011 under the Act, under the name of “La garderie les Ti-Papoutes”, beingfile #657127, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the name of the person registering referenced in Items#5, 7 and 8 of form 5 be corrected to read as follows: “Annick LeBlanc”.

Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 20 avril 2011 en vertu de la Loi sous le nom de « La garderie lesTi-Papoutes », dont le numéro d’appellation commerciale est 657127, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, que le nom dela personne enregistrant qui apparaît aux articles 5, 7 et 8 du formulaire 5 soit corrigé pour qu’il se lise comme suit : « Annick LeBlanc ».

_____________________________________________________

The Royal Gazette — May 18, 2011 614 Gazette royale — 18 mai 2011

HUDON’S SECURITY AND Alfred J. Hudon Bathurst 325266 2011 04 14INVESTIGATION AGENCY

BOIS FRANCOIS Francois Richard Acadieville 334955 2011 04 19

TINSEL THE CLOWN Raymond Mulholland Waasis 338478 2011 04 19

LORMAN EDUCATION LORMAN BUSINESS Fredericton 348616 2011 04 28SERVICES CENTER, INC.

NBTel BELL ALIANT REGIONAL Saint John 350917 2011 04 15COMMUNICATIONS INC.BELL ALIANT COMMUNICATIONS REGIONALES INC.

PICTURES IN THREAD Margaret Brown Lower Brighton 351228 2011 04 20

Canadian Manufacturers & Alliance of Manufacturers & Moncton 351587 2011 04 21Exporters/Manufacturiers et Exporters CanadaExportateurs du Canada Alliance des manufacturiers

et des exportateurs du Canada

BARNES DISTRIBUTION Barnes Group Canada Corp./ Saint John 352652 2011 04 26Le Groupe Barnes du Canada Cle.

KAR PRODUCTS Barnes Group Canada Corp./ Saint John 606761 2011 04 26Le Groupe Barnes du Canada Cle.

THE FASTENER CENTRE Barnes Group Canada Corp./ Saint John 606762 2011 04 26Le Groupe Barnes du Canada Cle.

THE FASTENER CENTRE/ Barnes Group Canada Corp./ Saint John 606763 2011 04 26KAR PRODUCTS Le Groupe Barnes du Canada

Cle.

KAR PRODUCTS/ Barnes Group Canada Corp./ Saint John 606765 2011 04 26THE FASTENER CENTRE Le Groupe Barnes du Canada

Cle.

3M CANADA 3M Canada Company- Saint John 611089 2011 04 18Compagnie 3M Canada

Boutique Daze 617654 N.-B. INC. Petit-Rocher 621340 2011 04 27

Penobsquis Practice Range Brenda McQuinn Penobsquis 623129 2011 04 19

Linguitek Denise Carrier Edmundston 623311 2011 04 21

JOISKO ENG. TRUSKO INC. Caraquet 623336 2011 04 15

KOFAB ENG. TRUSKO INC. Caraquet 623337 2011 04 15

SUNSHINE DISTRIBUTION Norman McGrath Allardville 623979 2011 04 18

Nicholson’s Septic Tank Cleaning DCMS HOLDINGS INC. Douglas 624166 2011 04 23

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

The Royal Gazette — May 18, 2011 615 Gazette royale — 18 mai 2011

DOWN HOME HEATING & Brian Halbot Minto 624281 2011 04 19VENTILATION

LA CAVE A VIN BOUDREAU Paul Boudreau Memramcook 624323 2011 04 18

AJMV Renovations Alvin Levesque Saint-Arthur 624324 2011 04 18

Leclerc Design Drafting Services Gaetan Leclerc Grand-Sault / Grand Falls 624435 2011 04 18

Dou Rod & Gun Aurele Soucy Saint-Léonard 624526 2011 04 21

Heritage Cleaners Doris O’Neill Willow Grove 624532 2011 04 19

Tweed-Eatery Harriett Tweedie Moncton 624636 2011 04 21

VILLA NEGUAC LE FOYER ST. BERNARD Neguac 624651 2011 04 20LTEE

Elite Dog Grooming & Academy Charlotte Cormier Moncton 624652 2011 04 21

CUT RIVER ROCK Thomas Mosher Oak Bay 624669 2011 04 19

AUDATEX AUDATEX CANADA, ULC Saint John 624820 2011 04 29

AUDATEX CANADA AUDATEX CANADA, ULC Saint John 624821 2011 04 29

ATLAS COPCO THIESSEN Atlas Copco Canada Inc. Saint John 625276 2011 04 29

Tension Span Alan Higgins Elgin 625285 2011 04 24

Esthetique Jenny-Lyne Esthetics Jenny-Lyne Boucher Moncton 625779 2011 04 26

Giza Scientific Michel Arsenault Moncton 626168 2011 04 27

STITCHES YM Inc. (Sales) Saint John 646239 2011 04 15

YM YM Inc. (Sales) Saint John 646241 2011 04 15

URBAN PLANET YM Inc. (Sales) Saint John 646243 2011 04 15

SIRENS YM Inc. (Sales) Saint John 646245 2011 04 15

_____________________________________________________

WORK UNLIMITED Colpitts Settlement 334096 2011 04 20

LOG CABIN RESTAURANT Hopewell Cape 348214 2011 04 28

Rouge Restro Lounge & Night Club Moncton 623727 2011 04 19

Edwards Sprinkler Moncton 630337 2011 04 29

Seniors Money Saint John 634942 2011 04 20

TAXI ST-BASILE ENR. Saint-Basile 635455 2011 04 06

Workplace Safety School of New Brunswick/ Drummond 636717 2011 04 19École de sécurite au travail du Nouveau-Brunswick

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

The Royal Gazette — May 18, 2011 616 Gazette royale — 18 mai 2011

The Caves Restaurant St. Martins 637639 2011 04 28

Stewart’s Cable Contracting Moncton 640889 2011 04 26

Colby Comeau Logging Juniper 642789 2011 04 27

Capewood Construction and Building Services Moncton 643778 2011 04 21

Hampton Computer Shop Hampton 646021 2011 04 18

AFFUTAGE CHALEUR SHARPENING Dunlop 647847 2011 04 27

Chubb Edwards Fredericton 650806 2011 04 26

Munchie Masters Vending Stilesville 651104 2011 04 27

_____________________________________________________

Gestion de Propriétés Vertical Marco J. Godbout Dieppe 655696 2011 04 20Property Management Ricky Côté

Mathieu McCaie

The Lawn Guys Dieppe Jason Seems Dieppe 656848 2011 04 07Marc Bourque

Superior Gas Liquids Partnership SUPERIOR GENERAL Moncton 657103 2011 04 19PARTNER INC.SUPERIOR PLUS LP

Gallant & Richard Entertainment Michelle Gallant Moncton 657158 2011 04 21François Richard

GOLDEN SWALLOW GROCERIES Yitao Xu Fredericton 657182 2011 04 20Youbei Ruan

_____________________________________________________

UTC Fire & Security Canada Chubb Edwards A UTC Fire & Mississauga 617491 2011 04 26Security Company

Chubb Edwards A UTC Fire & GE Security Canada Mississauga 617491 2011 04 06Security Company

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of firmname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement de raison sociale a été enregistré :

Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Date

Previous Name commerce ou Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale du représentant référence année mois jour

The Royal Gazette — May 18, 2011 617 Gazette royale — 18 mai 2011

Bourgoin Mouldings Armand Bourgoin DSL de Drummond / 622167 2011 04 18Carolle Bourgoin LSD of Drummond

Les Bleuetières Lainey Thériault Bruno Thériault Val-Doucet 624038 2011 04 19Bruno LaineyTheodule Lainey

SNC-SNAM, S.E.N.C. / SNC-SNAM, G.P. CENMC Canada Inc. Fredericton 624335 2011 04 18SNC-LAVALIN INC.SNAMPROGETTICANADA INC.

Santé Essentielle / Essential Health Benny Poirier Balmoral 624650 2011 04 21Jerry Vienneau

_____________________________________________________

Lazer-Tech Line Painting Bayside 621746 2011 04 15

_____________________________________________________

GE Security Canada GE Water & Process CSG Security 617491 2011 04 26Technologies Canada Corporation/Sécurité General Electric Canada/ CSF Corporation Generale Electrique du Canada 3234808 Nova Scotia

Limited

Chubb Edwards A UTC Fire & Counterforce Corporation 617491 2011 04 26Security Company

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement de société en nom collectif a été enregistré :

Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Datecommerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of member-ship of partnership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Retiring Partners Incoming Partners Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Associés sortants Nouveaux associés référence année mois jour

The Royal Gazette — May 18, 2011 618 Gazette royale — 18 mai 2011

TFI TRANSPORT 22 L.P. Saint John Québec / Quebec SMSS Corporate Services 656933 2011 04 12(NB) Inc.Saint John

GRAHAM DESIGN BUILD Saint John Manitoba SMSS Corporate Services 657112 2011 04 20SERVICES LP (NB) Inc.

Saint John

_____________________________________________________

NORREP PERFORMANCE 2010 FLOW- Alberta SMSS Corporate Services 650713 2011 04 27THROUGH LIMITED PARTNERSHIP (NB) Inc.

Saint John

_____________________________________________________

TFI TRANSPORT 3 L.P. Québec / Quebec 6291856 Canada Inc. Saint John 603214 2011 04 14

TFI TRANSPORT 17 L.P. Québec / Quebec 6422217 Canada Inc. Saint John 647109 2011 04 14

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-

ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership hasbeen filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-sée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Agent and Address Number DatePrincipal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limitedpartnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale aété déposée par :

ReferenceAgent and Address Number Date

Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of change of limited partnership or extra-provincial limited partnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de changement de société en commandite ou de sociétéen commandite extraprovinciale a été déposée :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date

Jurisdiction General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

The Royal Gazette — May 18, 2011 619 Gazette royale — 18 mai 2011

VENTE DE VÉHICULES À MOTEURSachez que le registraire des véhicules à moteur de la provincedu Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteursuivants le 18 mai 2011 :

Chrysler Neon 2002Numéro de série : 1C3ES76F22D595583Numéro d’immatriculation : ETE623-N.-É.Propriétaire immatriculé : LHPM Industrial Poly Liner IncVéhicule se trouvant actuellement chez AA Towing Ltd,MaugervilleKia Sportage 2005Numéro de série : KNDJE722X57085845Numéro d’immatriculation : GMV015Propriétaire immatriculé : David BishopVéhicule se trouvant actuellement chez AA Towing Ltd,MaugervilleChrysler Neon 2000Numéro de série : 1C3ES46C7YD524019Numéro d’immatriculation : GHL594Propriétaire immatriculé : Ashley CourierVéhicule se trouvant actuellement chez AA Towing Ltd,MaugervilleAutoneige Polaris XC600 1997Numéro de série : 3138199Numéro d’immatriculation : 809815-ONPropriétaire immatriculé : Rocky J. P. ValdronVéhicule se trouvant actuellement chez AA Towing Ltd,MaugervilleFord Taurus 1995Numéro de série : 1FALP52U7SG304500Numéro d’immatriculation : GEK144Propriétaire immatriculée : Colleen C. M. VautourVéhicule se trouvant actuellement chez AA Towing Ltd,MaugervilleLincoln Towncar 1998Numéro de série : 1LNFM81WY619505Numéro d’immatriculation : BVW420Propriétaire immatriculé : Ronald I. GoodineVéhicule se trouvant actuellement chez AA Towing Ltd,MaugervilleDodge Avenger 1998Numéro de série : 4B3AU42N2WE119107Numéro d’immatriculation : GIO211Propriétaire immatriculé : Bruce PolchiesVéhicule se trouvant actuellement chez AA Towing Ltd,MaugervilleNissan Sentra 1998Numéro de série : 3N1AB41DXWL039071Numéro d’immatriculation : BWA246Propriétaire immatriculé : Wenguo LiuVéhicule se trouvant actuellement chez AA Towing Ltd,Maugerville

Ministère de laSécurité publique

SALE OF MOTOR VEHICLESTake notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province ofNew Brunswick, will be disposing of the following vehicles onor after May 18, 2011:

2002, Chrysler NeonSerial No. 1C3ES76F22D595583License Plate: ETE623-NSRegistered Owner: LHPM Industrial Poly Liner IncVehicle located at AA Towing Ltd, Maugerville

2005, Kia SportageSerial No. KNDJE722X57085845License Plate: GMV015Registered Owner: David BishopVehicle located at AA Towing Ltd, Maugerville

2000, Chrysler NeonSerial No. 1C3ES46C7YD524019License Plate: GHL594Registered Owner: Ashley CourierVehicle located at AA Towing Ltd, Maugerville

1997, Polaris XC600 SVSerial No. 3138199License Plate: 809815-ONRegistered Owner: Rocky J. P. ValdronVehicle located at AA Towing Ltd, Maugerville

1995, Ford TaurusSerial No. 1FALP52U7SG304500License Plate: GEK144Registered Owner: Colleen C. M. VautourVehicle located at AA Towing Ltd, Maugerville

1998, Lincoln TowncarSerial No. 1LNFM81WY619505License Plate: BVW420Registered Owner: Ronald I. GoodineVehicle located at AA Towing Ltd, Maugerville

1998, Dodge AvengerSerial No. 4B3AU42N2WE119107License Plate: GIO211Registered Owner: Bruce PolchiesVehicle located at AA Towing Ltd, Maugerville

1998, Nissan SentraSerial No. 3N1AB41DXWL039071License Plate: BWA246Registered Owner: Wenguo LiuVehicle located at AA Towing Ltd, Maugerville

Department ofPublic Safety

The Royal Gazette — May 18, 2011 620 Gazette royale — 18 mai 2011

1998, Volks JettaSerial No. 3VWRA81H7WM262351License Plate: BXI585Registered Owner: Matt ComeauVehicle located at AA Towing Ltd, Maugerville

1993, Dodge CaravanSerial No. 2B4GH45R8PR375699License Plate: GNY863Registered Owner: Jason Nelson McCavourVehicle located at AA Towing Ltd, Maugerville

1999, Chev MalibuSerial No. 1G1ND52T7X6158947License Plate: ESY119-NSRegistered Owner: Christa Nichole MacDonaldVehicle located at AA Towing Ltd, Maugerville

________________

SALE OF MOTOR VEHICLESTake notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province ofNew Brunswick, will be disposing of the following vehicles onor after May 18, 2011:

1994, BMW318ISSerial No. WBABE632XRJC16780License Plate: EPF775-NSRegistered Owner: Kimberley Ann McCormickVehicle located at Gautreau’s Used Auto Parts Ltd,Memramcook1993, Ford EscortSerial No. 1FABP11J3PW247611License Plate: NAV303Registered Owner: Harry NearVehicle located at Gautreau’s Used Auto Parts Ltd,Memramcook1997, Pontiac SunfireSerial No. 3G2JD12TXVS801710License Plate: GYI106Registered Owner: Christie DunphyVehicle located at Gautreau’s Used Auto Parts Ltd,Memramcook2001, Olds AuroraSerial No. 1G3GR64H114117832License Plate: GUU336Registered Owner: Sarah BailieVehicle located at Gautreau’s Used Auto Parts Ltd,Memramcook

Volks Jetta 1998Numéro de série : 3VWRA81H7WM262351Numéro d’immatriculation : BXI585Propriétaire immatriculé : Matt ComeauVéhicule se trouvant actuellement chez AA Towing Ltd,MaugervilleDodge Caravan 1993Numéro de série : 2B4GH45R8PR375699Numéro d’immatriculation : GNY863Propriétaire immatriculé : Jason Nelson McCavourVéhicule se trouvant actuellement chez AA Towing Ltd,MaugervilleChev Malibu 1999Numéro de série : 1G1ND52T7X6158947Numéro d’immatriculation : ESY119-N.-É.Propriétaire immatriculée : Christa Nichole MacDonaldVéhicule se trouvant actuellement chez AA Towing Ltd,Maugerville

________________

VENTE DE VÉHICULES À MOTEURSachez que le registraire des véhicules à moteur de la provincedu Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteursuivants le 18 mai 2011 :

BMW318IS 1994Numéro de série : WBABE632XRJC16780Numéro d’immatriculation : EPF775-N.-É.Propriétaire immatriculée : Kimberley Ann McCormickVéhicule se trouvant actuellement chez Gautreau’s UsedAuto Parts Ltd, MemramcookFord Escort 1993Numéro de série : 1FABP11J3PW247611Numéro d’immatriculation : NAV303Propriétaire immatriculé : Harry NearVéhicule se trouvant actuellement chez Gautreau’s UsedAuto Parts Ltd, MemramcookPontiac Sunfire 1997Numéro de série : 3G2JD12TXVS801710Numéro d’immatriculation : GYI106Propriétaire immatriculée : Christie DunphyVéhicule se trouvant actuellement chez Gautreau’s UsedAuto Parts Ltd, MemramcookOlds Aurora 2001Numéro de série : 1G3GR64H114117832Numéro d’immatriculation : GUU336Propriétaire immatriculée : Sarah BailieVéhicule se trouvant actuellement chez Gautreau’s UsedAuto Parts Ltd, Memramcook

The Royal Gazette — May 18, 2011 621 Gazette royale — 18 mai 2011

PROVINCE OF NEW BRUNSWICKCOUNTY OF WESTMORLAND

NOTICE OF MORTGAGE SALETO: ROYAL OAKS REAL ESTATE INC., Mortgagor;

AND TO: GREEN HUNT WEDLAKE INC., as trustee ofRoyal Oaks Real Estate Inc.;AND TO: RONALD JOSEPH GOGUEN, Guarantor;AND TO: HEATHER ANN GOGUEN, Guarantor;AND TO: BLUE CHIP INVESTMENTS INC., Guarantor;AND TO: DISTNET INC., Subsequent Mortgagee;AND TO: CITY OF MONCTON, Subsequent Mortgagee;

AND TO: TERRAIN GROUP INC., Judgment Creditor;AND TO: MODERN CONSTRUCTION (1983) LIMITED,Judgment Creditor;AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN.WHEREAS by virtue of a Collateral Mortgage (the “First Mort-gage”) dated July 14, 2005 and registered in the Registry ofLand Titles under the Land Titles Act in the City of Monctonand County of Westmorland on July 20, 2005 as Number20633955, Royal Oaks Real Estate Inc. (the “Mortgagor”)mortgaged to RIC New Brunswick Inc. as Trustee (the “Mort-gagee”) the lands and premises described therein (the “landsand premises”);

AND WHEREAS by virtue of a Mortgage (the “Second Mort-gage”) dated November 24, 2005 and registered in the Registryof Land Titles under the Land Titles Act in the City of Monctonand County of Westmorland on November 24, 2005 as Number21352563, the Mortgagor mortgaged to the Mortgagee the landsand premises;

AND WHEREAS the First Mortgage and the Second Mortgageare hereinafter referred to as the “Security”;AND WHEREAS the Mortgagor has defaulted under the termsand conditions of the Security;NOTICE IS HEREBY GIVEN that under and by virtue of theSecurity and under section 44 of the Property Act of NewBrunswick, there will, for the purpose of obtaining payment ofthe monies secured by the Security, be sold by public auction ator near the entrance of the Moncton City Hall Building,655 Main Street, Moncton, N.B., on May 25, 2011, at 2:00 p.m.,local time, the lands and premises, together with all buildingsand improvements thereon and all privileges and appurtenancesthereto belongings or in any way appertaining.The lands and premises are identified by PIDs 70488473,70334172, 70351838, 70351853, 70343959, 70389077,70389085, 70389093, 70354402, 70334180, 70409800,70431697, 70344940, 70334206, 70343033, 70347497,70347455, 70347489, 70390448, 70390455, 70390463,70334248, 70342985, 70360797, 70337175, 70336987,70424759, 70336995, 70337001, 70337019, 70337035,70337092, 70337100, 70337118, 70337126, 70427307,

Notices of Sale

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICKCOMTÉ DE WESTMORLAND

AVIS DE VENTE DE BIENS HYPOTHÉQUÉSDESTINATAIRES : ROYAL OAKS REAL ESTATE INC.,débiteur hypothécaire;GREEN HUNT WEDLAKE INC., fiduciaire de Royal OaksReal Estate Inc.;RONALD JOSEPH GOGUEN, garant;HEATHER ANN GOGUEN, garante;BLUE CHIP INVESTMENTS INC., garant;DISTNET INC., créancier hypothécaire postérieur;VILLE DE MONCTON, créancière hypothécaire posté-rieure;TERRAIN GROUP INC., créancier sur jugement;MODERN CONSTRUCTION (1983) LIMITED, créanciersur jugement;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.ATTENDU qu’en vertu d’une hypothèque subsidiaire (la« première hypothèque ») constituée le 14 juillet 2005 et enre-gistrée dans le registre des titres fonciers en vertu de la Loi surl’enregistrement foncier dans la ville de Moncton, comté deWestmorland, le 20 juillet 2005, sous le numéro 20633955,Royal Oaks Real Estate Inc. (le « débiteur hypothécaire ») a hy-pothéqué à RIC New Brunswick Inc., fiduciaire (le « créancierhypothécaire ») les terrains et bâtiments désignés aux présentes(les « terrains et bâtiments »);ET ATTENDU qu’en vertu d’une hypothèque (la « deuxièmehypothèque ») constituée le 24 novembre 2005 et enregistréedans le registre des titres fonciers, en vertu de la Loi sur l’enre-gistrement foncier, dans la ville de Moncton, comté de West-morland, le 24 novembre 2005, sous le numéro 21352563, ledébiteur hypothécaire a hypothéqué au créancier hypothécaireles terrains et les bâtiments; ET ATTENDU qu’il est ci-après fait référence aux première etdeuxième hypothèques comme la « sûreté »;ET ATTENDU que le débiteur hypothécaire a manqué à sesobligations en vertu des conditions de la sûreté;SACHEZ qu’en vertu de la sûreté et de l’article 44 de la Loi surles biens du Nouveau-Brunswick, seront vendus aux enchèrespubliques en vue d’acquitter les sommes garanties par la sûreté,dans l’entrée de l’hôtel de ville de Moncton, ou tout près,655, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick), le 25 mai2011, à 14 h, heure locale, les terrains et dépendances, ainsi quetous les bâtiments qui s’y trouvent et les améliorations qui y ontété apportées, de même que les privilèges et dépendances quis’y rattachent.Les terrains et dépendances ont les numéros d’identification70488473, 70334172, 70351838, 70351853, 70343959,70389077, 70389085, 70389093, 70354402, 70334180,70409800, 70431697, 70344940, 70334206, 70343033,70347497, 70347455, 70347489, 70390448, 70390455,70390463, 70334248, 70342985, 70360797, 70337175,70336987, 70424759, 70336995, 70337001, 70337019,70337035, 70337092, 70337100, 70337118, 70337126,

Avis de vente

The Royal Gazette — May 18, 2011 622 Gazette royale — 18 mai 2011

70427299, 70400726, 70400676 which are all situate at or nearthe Royal Oaks Subdivision, Elmwood Drive, Moncton, NewBrunswick.DATED at Moncton, N.B. this 21st day of April, 2011.

Luc J. Elsliger, Stewart McKelvey, Solicitors for RIC NewBrunswick Inc. as Trustee, 644 Main Street, Suite 601,Moncton, N.B. E1C 9N4, Telephone: 506-853-1970

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Marcel Joseph Vautour and Manon LePage Vautour, bothbankrupts and original Mortgagors; and to Allan Marshall &Associates Inc., trustee of the Estates of Marcel Joseph Vautourand Manon LePage Vautour; and to all others whom it may con-cern. Sale pursuant to terms of the mortgage and the PropertyAct, R.S.N.B. 1973, c.P-19, as amended. Freehold property sit-uate at 227 Collette Road, Collette, in the County of Northum-berland and Province of New Brunswick, and being identifiedas PID 40446114.Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, Mort-gagee and holder of the first mortgage. Sale to be held at theMiramichi Court House, 673 King George Highway,Miramichi, N.B., on May 26, 2011, at the hour of 11:00 a.m., lo-cal time. See advertisement of Notice of Mortgage Sale in theMiramichi Leader dated April 27, May 4, May 11, and May 18,2011.

McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,Per: R. Scott Wilson, Suite 1700, Brunswick Square, 1 GermainStreet, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick, E2L 4R8,Telephone: 506-643-6500, Facsimile: 506-643-6505

________________

TO: JAMIE RICHARD THOMAS;AND TO: LACEY LEIGH KINNEY;AND TO: MACPHERSON SHEPARD;AND TO: PROGRESSIVE CREDIT UNION LIMITED(previously known as CARLETON PIONEER CREDITUNION LIMITED).NOTICE IS HEREBY GIVEN that under and by virtue of a cer-tain Indenture of Mortgage bearing date the 27th day of July,2004 and registered in the Office of the Registrar of Deeds inand for the County of Carleton on the 12th day of August, 2004as Number 18908245 made between JAMIE RICHARDTHOMAS AND LACEY LEIGH KINNEY, as Mortgagorsand PROGRESSIVE CREDIT UNION LIMITED (previ-ously known as CARLETON PIONEER CREDIT UNIONLIMITED), as Mortgagee, and under and by virtue of the Prop-erty Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19, there will, for the purpose ofobtaining payment of monies secured by the said Indenture ofMortgage, default having been made in the payment thereof, besold at public auction at the offices of McCue BrewerDickinson, 179 Broadway Street, Woodstock, New

70427307, 70427299, 70400726, 70400676, et sont tous situéssur le lotissement Royal Oaks, ou tout près, promenadeElmwood, Moncton (Nouveau-Brunswick).FAIT à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 21 avril 2011.

Luc J. Elsliger, du cabinet Stewart McKelvey, avocats deRIC New Brunswick Inc., fiduciaire, 644, rue Main, bureau601, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 9N4, téléphone :506-853-1970

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Destinataires : Marcel Joseph Vautour et Manon LePageVautour, faillis et débiteurs hypothécaires originaires; AllanMarshall & Associates Inc., syndic du patrimoine de MarcelJoseph Vautour et de Manon LePage Vautour; et tout autre in-téressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions del’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens,L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 227, che-min Collette, Collette, comté de Northumberland, province duNouveau-Brunswick, et ayant le NID 40446114.Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, titu-laire de la première hypothèque. La vente aura lieu le 26 mai2011, à 11 h, heure locale, au palais de justice de Miramichi,673, route King George, Miramichi (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions du 27 avril et des4, 11 et 18 mai 2011 du Miramichi Leader.

R. Scott Wilson, du cabinet McInnes Cooper, avocats de La Ban-que Toronto-Dominion, bureau 1700, Brunswick Square, 1, rueGermain, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 4R8;téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505

________________

DESTINATAIRES : JAMIE RICHARD THOMAS;LACEY LEIGH KINNEY;MACPHERSON SHEPARD;PROGRESSIVE CREDIT UNION LIMITED (ancienne-ment connue sous le nom de CARLETON PIONEER CRE-DIT UNION LIMITED).SACHEZ qu’en vertu de l’acte d’hypothèque constitué le27 juillet 2004, et enregistré au bureau de l’enregistrement ducomté de Carleton le 12 août 2004, sous le numéro 18908245,entre JAMIE RICHARD THOMAS ET LACEY LEIGHKINNEY, débiteurs hypothécaires, et PROGRESSIVE CRE-DIT UNION LIMITED (anciennement connue sous le nomde CARLETON PIONEER CREDIT UNION LIMITED),créancière hypothécaire, en application de la Loi sur les biens,L.R.N.-B. 1973, c. P-19, seront vendus aux enchères publiquesen vue d’acquitter les sommes garanties par ledit acte d’hypo-thèque, étant donné le défaut d’en effectuer le paiement, aucabinet d’avocats McCue Brewer Dickinson, 179, rueBroadway, Woodstock (Nouveau-Brunswick), le 1er juin2011, à 11 h, heure locale, le terrain et les bâtiments, connus

The Royal Gazette — May 18, 2011 623 Gazette royale — 18 mai 2011

Brunswick, on 1st day of June, 2011, at the hour of eleveno’clock (11:00 a.m.) in the forenoon, local time, the lands andpremises known as House and Lot, 744 Central Street,Centreville, New Brunswick and having PID number10080786.DATED at the Town of Woodstock, in the Province of NewBrunswick, this 27th day of April, 2011.

Progressive Credit Union Limited (previously known asCarleton Pioneer Credit Union Limited), Per: James H.McCue, Solicitor for Mortgagee

For further particulars of the sale apply to: James H. McCue,Solicitor for Mortgagee, 179 Broadway Street, Woodstock, NBE7M 1B7, Tel: 506-325-2835, Fax: 506-328-6248

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1

TO: CAMCO CONSTRUCTION LTD., ORIGINALMORTGAGOR AND OWNER OF THE EQUITY OFREDEMPTION; MATTHEWS EQUIPMENT LIMITED,JUDGMENT CREDITOR; EMCO CORPORATION,JUDGMENT CREDITOR; RIVERVIEW ELECTRIC,JUDGMENT CREDITOR; AND TRI-PROVINCEENTERPRISES (1984) LTD., JUDGMENT CREDITOR;AND ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN.

Sale under the provisions of a certain Mortgage dated April 30,2007, between Camco Construction Ltd., as Mortgagor, andToronto-Dominion Bank, as Mortgagee, and registered in theWestmorland County Land Titles Office on May 7, 2007, asnumber 23786123 (the “Mortgage”) and under section 44 of theProperty Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19 and amendments thereto.Freehold lands and premises, including any personal property,situated at 2955 Route 132, in the Village of Scoudouc, in theCounty of Westmorland, Province of New Brunswick and hav-ing PID Numbers 9007006 and 885293.

Notice of sale given by Toronto-Dominion Bank, holder of theMortgage. Sale to be held on June 1, 2011, at the hour of 11:00a.m., by public auction at the Town Hall, at the Town ofShediac, New Brunswick. See advertisements in Times &Transcript dated May 5, May 11, May 18, and May 25, 2011.

Barry Spalding, Solicitors for Toronto-Dominion Bank, PerPhilippe H. Richard, 55 Union Street, Suite 710, P.O. Box 6010,Saint John, New Brunswick, E2L 5B7, Telephone:506-633-4226, Facsimile: 506-633-4206

________________

comme la maison et lot situés au 744, rue Central,Centreville (Nouveau-Brunswick), et dont le NID est10080786.

FAIT dans la ville de Woodstock, province du Nouveau-Brunswick, le 27 avril 2011.

Progressive Credit Union Limited (anciennement connuesous le nom de Carleton Pioneer Credit Union Limited),créancière hypothécaire, par son avocat James H. McCue

Pour obtenir plus de détails relativement à la vente, communi-quer avec James H. McCue, avocat de la créancière hypothé-caire, 179, rue Broadway, Woodstock (Nouveau-Brunswick)E7M 1B7, tél. : 506-325-2835; téléc. : 506-328-6248

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1

DESTINATAIRES : CAMCO CONSTRUCTION LTD.,DÉBITEUR HYPOTHÉCAIRE ORIGINAIRE ET PRO-PRIÉTAIRE DU DROIT DE RACHAT; MATTHEWSEQUIPMENT LIMITED, CRÉANCIER SUR JUGE-MENT; EMCO CORPORATION, CRÉANCIER SUR JU-GEMENT; RIVERVIEW ELECTRIC, CRÉANCIER SURJUGEMENT; TRI-PROVINCE ENTERPRISES (1984)LTD., CRÉANCIER SUR JUGEMENT; ET TOUTAUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque établi le 30 avril 2007 entre Camco Construction Ltd.,débiteur hypothécaire, et La Banque Toronto-Dominion,créancière hypothécaire, et enregistré au bureau de l’enregistre-ment foncier du comté de Westmorland le 7 mai 2007 sous lenuméro 23786123 (l’« acte d’hypothèque »), et en vertu de l’ar-ticle 44 de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Terrainset bâtiments en tenure libre, y compris tout bien personnel, si-tués au 2955, route 132, village de Scoudouc, comté deWestmorland, province du Nouveau-Brunswick, et dont lesNID sont 9007006 et 885293.Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, titu-laire de l’hypothèque. La vente aura lieu le 1er juin 2011, à 11 h,par encan public, à l’hôtel de ville de Shediac, au Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans les éditions des5, 11, 18 et 25 mai 2011 du Times & Transcript.

Philippe H. Richard, du cabinet Barry Spalding, 55, rue Union,bureau 710, C.P. 6010, Saint John (Nouveau-Brunswick)E2L 5B7, téléphone : 506-633-4226, télécopieur : 506-633-4206

________________

The Royal Gazette — May 18, 2011 624 Gazette royale — 18 mai 2011

JOSEPH RONALD FALLU, Original Mortgagor and ownerof the equity of redemption; CAISSE POPULAIRERESTIGOUCHE LTÉE, first Mortgagee and holder of theMortgage; and others whom it may concern. Sale conducted un-der the terms of the Mortgage and the Property Act, being Chap-ter P-19, R.S.N.B., 1973, s.44 as amended. Freehold property at65-67 Water Street, in Campbellton, in the County ofRestigouche and Province of New Brunswick. Notice of Salegiven by CAISSE POPULAIRE RESTIGOUCHE LTÉE. Saleat the Mail Promenade, 410 William Street, in the Town ofDalhousie, in the County of Restigouche and Province of NewBrunswick on June 1st, 2011, at the hour of 11:00 a.m., localtime. See advertisement in the weekly newspaper L’Aviron.

Larry Landry of Larry Landry C.P. Inc., Solicitor for the Mort-gagee, CAISSE POPULAIRE RESTIGOUCHE LTÉE

________________

TO: RANDOLPH MICHAEL GUITAR and SANDRA LEEGUITAR, of 116 Crockett Street, Fredericton, in the County ofYork and Province of New Brunswick, Mortgagor;

AND TO: HOUSEHOLD REALTY CORPORATIONLIMITED, of 1012 Prospect Street, Unit F, Fredericton, NBE3B 3C1, Second Mortgagee;AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.Freehold premises known as PID 1552645, situate, lying andbeing at 116 Crocket Street, Fredericton, in the County of Yorkand Province of New Brunswick.Notice of Sale given by the Toronto-Dominion Bank, holder ofthe first mortgage.Sale on the 9th day of June, 2011, at 11:00 a.m., at theFredericton Court House, 427 Queen Street, in the City ofFredericton, in the County of York, New Brunswick.See advertisement in The Daily Gleaner.Sale conducted under the terms of the mortgage and the Prop-erty Act, R.S.N.B., 1973, Chapter P-19, as amended.

DATED at the City of Moncton, in the County of Westmorlandand Province of New Brunswick, this 26th day of April, 2011.

WILBUR & WILBUR Solicitors for the Mortgagee, TheToronto-Dominion Bank

The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette Coordinator, in the Queen’sPrinter Office, no later than noon, at least seven days prior toWednesday’s publication. Each document must be separatefrom the covering letter. Signatures on documents must be im-mediately followed by the printed name. The Queen’s Printermay refuse to publish a document if any part of it is illegible,and may delay publication of any document for administrativereasons.

Notice to Advertisers

JOSEPH RONALD FALLU, débiteur hypothécaire originaireet propriétaire du droit de rachat; CAISSE POPULAIRERESTIGOUCHE LTÉE, créancière hypothécaire et titulaire del’hypothèque de premier rang; et tout autre intéressé éventuel.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, chap. P-19,art.44, dans sa forme modifiée. Biens en tenure libre situés au65-67, rue Water, à Campbellton, dans le comté deRestigouche, au Nouveau-Brunswick. Avis de vente donné parla CAISSE POPULAIRE RESTIGOUCHE LTÉE. La venteaura lieu le 1er juin 2011, à 11 heures, heure locale, au MailPromenade, 410, rue William, à Dalhousie, au Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le journal hebdoma-daire L’Aviron.

Larry Landry, Larry Landry C.P. Inc., avocat de la créancièrehypothécaire, CAISSE POPULAIRE RESTIGOUCHE LTÉE

________________

DESTINATAIRES : RANDOLPH MICHAEL GUITAR etSANDRA LEE GUITAR, du 116, rue Crockett, Fredericton,comté de York, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hy-pothécaires;HOUSEHOLD REALTY CORPORATION LIMITED,1012, rue Prospect, unité F, Fredericton (Nouveau-Brunswick)E3B 3C1, deuxième créancière hypothécaire;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Lieux en tenure libre situés au 116, rue Crockett, Fredericton,comté de York, province du Nouveau-Brunswick, et dont le nu-méro d’identification est 1552645.Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, titu-laire de la première hypothèque.La vente aura lieu le 9 juin 2011, à 11 h, au palais de justice deFredericton, 427, rue Queen, ville de Fredericton, comté deYork, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le journal The Daily Gleaner.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, cha-pitre P-19.FAIT dans la ville de Moncton, comté de Westmorland, pro-vince du Nouveau-Brunswick, le 26 avril 2011.

WILBUR & WILBUR, avocats de la créancière hypothécaire,La Banque Toronto-Dominion

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, à midi, aumoins sept jours avant le mercredi de publication. Chaqueavis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signa-taires doivent suivre immédiatement la signature. L’Impri-meur de la Reine peut refuser de publier un avis dont une par-tie est illisible et retarder la publication d’un avis pour desraisons administratives.

Avis aux annonceurs

The Royal Gazette — May 18, 2011 625 Gazette royale — 18 mai 2011

Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.

The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:

http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-e.asp

NoticesCost perInsertion

Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill

$ 20

Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,

1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30Any document under the Political Process Financing Act $ 20

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act

$ 20

Notice under the Quieting of Titles Act (Form 70B)Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

$120

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)

$ 20

Notice of a correction charge isthe same as

for publishing the original document

Any other document $3.50 for each cm or less

Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établià l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-f.asp

AvisCoût par parution

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le

financement de l’activité politique20 $

Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions

20 $

Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété(Formule 70B)

Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 posur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur

20 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés

pour la publication du

document original

Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou

moins

The Royal Gazette — May 18, 2011 626 Gazette royale — 18 mai 2011

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe Office of the Queen’s Printer, at $4.00 per copy plus 13%tax, plus shipping and handling where applicable.

Office of the Queen’s Printer670 King Street, Room 117

P.O. Box 6000Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-2520 Fax: 506-457-7899E-mail: [email protected]

Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, pour la sommede 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 13 %, ainsi que les fraisapplicables de port et de manutention.

Bureau de l’Imprimeur de la Reine670, rue King, pièce 117

C.P. 6000Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1Tél. : 506-453-2520 Téléc. : 506-457-7899

Courriel : [email protected]

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés